CT ICE (HOLDINGS) LIMITED

CT ICE (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCT ICE (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05094965
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COOLTRADER (HOLDINGS) LIMITED07 lug 200407 lug 2004
    BROOMCO (3442) LIMITED05 apr 200405 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Nicholas Canning come amministratore in data 22 set 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 24 mar 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 25 mar 2016

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2016

    Stato del capitale al 27 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 27 mar 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2015

    Stato del capitale al 29 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Duncan Andrew Vaughan come segretario in data 31 dic 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jayne Katherine Burrell come segretario in data 31 dic 2014

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 17/12/2014
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2014

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Canning il 23 set 2014

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2014

    Stato del capitale al 15 apr 2014

    • Capitale: GBP 2,850,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed cooltrader (holdings) LIMITED\certificate issued on 16/10/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name16 ott 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 set 2012

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 set 2012

    RES15

    Chi sono gli amministratori di CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUGHAN, Duncan Andrew
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Segretario
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    193761240001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector151680990001
    WALKER, Malcolm Conrad, Sir
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    United KingdomBritish,Director161541770001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Segretario
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    BURRELL, Jayne Katherine
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Segretario
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    159099850001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Segretario
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    BritishDirector42467790003
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BIRCH, Andrew Richard
    Swn Y Dwr
    Wern Road Minera
    LL11 3DW Wrexham
    Amministratore
    Swn Y Dwr
    Wern Road Minera
    LL11 3DW Wrexham
    BritishCompany Director110457030001
    BRUNING, Christian Lewis
    Windmill Bank
    Selsfield Common
    RH19 4LW East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Windmill Bank
    Selsfield Common
    RH19 4LW East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritishVenture Capitalist96365150002
    CANNING, Nicholas
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritishDirector112318560002
    ERRINGTON, Andrew Neil
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector81671320002
    HARALDSSON, Palmi
    Brekkutun 13
    Reykjavik
    200
    Iceland
    Amministratore
    Brekkutun 13
    Reykjavik
    200
    Iceland
    IcelandicDirector91876750001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector42467790003
    SCRAGG, Neil Grant
    9 Townsend Drive
    AL3 5RB St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Townsend Drive
    AL3 5RB St. Albans
    Hertfordshire
    BritishInvestment Director88324810001
    WALKER, Steven John
    Cobbetts Solicitors
    Ship Canal House, King Street
    M2 4WB Manchester
    Amministratore
    Cobbetts Solicitors
    Ship Canal House, King Street
    M2 4WB Manchester
    EnglandBritishDirector40023810004
    WATTS, Colin
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector99495740001
    YATES, Timothy Charles
    The Old Pump House
    Station Road, Desford
    LE9 9FP Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Pump House
    Station Road, Desford
    LE9 9FP Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector34910760002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CT ICE (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ct Ice Acquisitions Limited
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Secon Avenue
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Secon Avenue
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CT ICE (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 apr 2012
    Consegnato il 13 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 13 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of accession
    Creato il 11 apr 2007
    Consegnato il 26 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 31 mar 2006
    Consegnato il 13 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Islands Hf (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No. 2
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 29 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0