QM CORPORATION LIMITED

QM CORPORATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQM CORPORATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05095087
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QM CORPORATION LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova QM CORPORATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    SMITH COOPER
    47 New Walk
    LE1 6TE Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QM CORPORATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EDGER 385 LIMITED05 apr 200405 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di QM CORPORATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per QM CORPORATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Derwent House Cranfield Technology Park University Way Cranfield Bedfordshire MK43 0AZ in data 15 giu 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 giu 2011

    LRESSP

    Cessazione della carica di Henning Sveder come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Henning Sveder come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Sareyko come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Henning Sveder come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 ago 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2011

    Stato del capitale al 03 mag 2011

    • Capitale: GBP 399,998
    SH01

    Cessazione della carica di Alistair Agnew come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve the sale of share capital 31/08/2010
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Michael Hallen come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Anahory come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Thomas Peter Sareyko come amministratore

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 ago 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Lars Gustaf Hallen il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lincoln Lodge Castlethorpe Milton Keynes Buckinghamshire MK19 7HJ in data 01 mar 2010

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di QM CORPORATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANAHORY, David
    New Walk
    LE1 6TE Leicester
    47
    Amministratore
    New Walk
    LE1 6TE Leicester
    47
    EnglandBritish127347820001
    FINCH, David
    Tailors House 27 High Street
    Swinderby
    LN6 9LW Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    Tailors House 27 High Street
    Swinderby
    LN6 9LW Lincoln
    Lincolnshire
    British102210250001
    GREEN, Terence
    3 Milton Road
    CV37 7LZ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    3 Milton Road
    CV37 7LZ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British108069660001
    SVEDER, Henning
    Ramarkesvagen 13
    43741 Lindome
    -
    Lindome
    Sweden
    Segretario
    Ramarkesvagen 13
    43741 Lindome
    -
    Lindome
    Sweden
    Swedish136613890001
    TELL, Bjorn Ingemar
    Masgatan 17,
    444 55 Stenungsund
    Sweden
    Segretario
    Masgatan 17,
    444 55 Stenungsund
    Sweden
    Swedish108891250001
    CRESCENT HILL LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Segretario nominato
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024050001
    AGNEW, Alistair
    Gloucester Place
    SL4 2AJ Windsor
    8
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gloucester Place
    SL4 2AJ Windsor
    8
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136612870001
    AGNEW, Alistair
    Flat 1 16 North Common Road
    Ealing
    W5 2QB London
    Amministratore
    Flat 1 16 North Common Road
    Ealing
    W5 2QB London
    British96244030001
    BROWN, Graham Martin
    Bayswater House Plowden Park
    OX9 5SX Aston Rowant
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bayswater House Plowden Park
    OX9 5SX Aston Rowant
    Oxfordshire
    EnglandBritish94522730001
    FINCH, David
    Tailors House 27 High Street
    Swinderby
    LN6 9LW Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    Tailors House 27 High Street
    Swinderby
    LN6 9LW Lincoln
    Lincolnshire
    British102210250001
    GREEN, Terence Ronald
    3 Milton Road
    CV37 7LZ Stratford Upon Avon
    Amministratore
    3 Milton Road
    CV37 7LZ Stratford Upon Avon
    British43558330005
    HALLEN, Michael Lars Gustaf
    Torild Wulffsg 32
    Gothenburg
    41319
    Sweden
    Amministratore
    Torild Wulffsg 32
    Gothenburg
    41319
    Sweden
    SwedenSwedish137202650001
    KLINCKE, Michael Ronald
    33 Ditton Reach
    KT7 0XB Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    33 Ditton Reach
    KT7 0XB Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish1143660002
    MACKENZIE, Kelvin Calder
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish141795340001
    PEARSON, David Charles
    9 The Warren
    AL5 2NH Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 The Warren
    AL5 2NH Harpenden
    Hertfordshire
    UkUk60337060001
    SAREYKO, Thomas Peter
    Cranfield Technology Park
    University Way
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    Amministratore
    Cranfield Technology Park
    University Way
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    SwedenSwedish152408210001
    SPIEKMAN, Marlies
    Church Farm 7 Mill Lane
    Woolstone
    MK15 0AJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Farm 7 Mill Lane
    Woolstone
    MK15 0AJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British109600060001
    STRABERG, Ake Birger
    Forbindelsevagen 41
    429 30 Kullavik
    Sweden
    Amministratore
    Forbindelsevagen 41
    429 30 Kullavik
    Sweden
    Swedish108891300001
    SVEDER, Henning
    Ramarkesvagen 13
    43741 Lindome
    -
    Lindome
    Sweden
    Amministratore
    Ramarkesvagen 13
    43741 Lindome
    -
    Lindome
    Sweden
    SwedenSwedish136613890001
    TELL, Bjorn Ingemar
    Masgatan 17,
    444 55 Stenungsund
    Sweden
    Amministratore
    Masgatan 17,
    444 55 Stenungsund
    Sweden
    Swedish108891250001
    WILLIAMS, Bernard
    2 Cinnamon Grove
    Walnut Tree
    MK7 7EL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Cinnamon Grove
    Walnut Tree
    MK7 7EL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish177036610002
    ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024040001

    QM CORPORATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share charge
    Creato il 12 lug 2007
    Consegnato il 21 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all of the shares and all corresponding related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) (the "Security Agent")
    Transazioni
    • 21 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 24 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as edger 385 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 24 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as edger 385 limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 24 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as edger 385 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any accounts of the company with the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    QM CORPORATION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 mag 2012Data di scioglimento
    07 giu 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Phillip Walter Harlow
    47 New Walk
    LE1 6TE Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    47 New Walk
    LE1 6TE Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0