WFA (UK) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WFA (UK) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05096119 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WFA (UK) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WFA (UK) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 3 Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth Hampshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WFA (UK) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALL GEAR HOLDINGS LIMITED | 06 apr 2004 | 06 apr 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WFA (UK) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per WFA (UK) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul James Overall il 01 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Blake il 01 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Grant David Bartholomew il 01 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione di The Taylor Cocks Partnership Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Taylorcocks Group Ltd come persona con controllo significativo il 30 apr 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2018 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di The Taylor Cocks Partnership Limited come persona con controllo significativo il 22 dic 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 1 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in parte | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Adam Christopher Suffolk come amministratore in data 22 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Grant David Bartholomew come amministratore in data 22 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul James Overall come amministratore in data 22 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Adam Keyes come amministratore in data 22 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Abbey House, Hickleys Court South Street Farnham Surrey GU9 7QQ a 3 Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham Portsmouth Hampshire PO6 3th in data 03 gen 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2017 con aggiornamenti | 8 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Steven Beaumont il 12 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Blake il 12 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WFA (UK) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCKLAND, Miles Andrew Nicholas | Segretario | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | British | 106088710002 | ||||||
| AUCKLAND, Miles Andrew Nicholas | Amministratore | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | United Kingdom | British | 106088710002 | |||||
| BARTHOLOMEW, Grant David | Amministratore | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | United Kingdom | British | 216931610002 | |||||
| BEAUMONT, Steven | Amministratore | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | England | British | 133694020004 | |||||
| BLAKE, James Martin | Amministratore | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | England | British | 226799730001 | |||||
| KEYES, Richard Adam | Amministratore | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | England | British | 223353410001 | |||||
| OVERALL, Paul James | Amministratore | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | England | British | 244114240001 | |||||
| SUFFOLK, Adam Christopher | Amministratore | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | United Kingdom | British | 216771160001 | |||||
| RAPLEY, Linda Susan | Segretario | 40 Keephatch Road RG40 1QJ Wokingham Berkshire | British | 93229000001 | ||||||
| COOPER, Stephen David | Amministratore | 10 Benbricke Green RG42 2EU Bracknell Berkshire | England | British | 93229070001 | |||||
| DAY, Stephen James | Amministratore | 30 Brook Hill OX20 1JE Woodstock Oxfordshire | United Kingdom | British | 87073250002 | |||||
| KYLE, Christopher | Amministratore | Acorn Business Centre, Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 51051250001 | |||||
| RAPLEY, Linda Susan | Amministratore | 40 Keephatch Road RG40 1QJ Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 93229000001 | |||||
| WALKER, Allison Victoria | Amministratore | Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 96313480001 | |||||
| WEBB, Katharine Elizabeth | Amministratore | 7 Winchester Road Four Marks GU34 5HD Alton Hampshire | British | 106088530001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WFA (UK) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylorcocks Group Ltd | 30 apr 2018 | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| The Taylor Cocks Partnership Limited | 22 dic 2017 | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Miles Andrew Nicholas Auckland | 06 apr 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Steven Beaumont | 06 apr 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr James Blake | 06 apr 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WFA (UK) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of securities(UK) | Creato il 22 mag 2006 Consegnato il 07 giu 2006 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on any stocks shares bonds warrants or securities (certified or uncertified) named in any schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of deposit | Creato il 21 dic 2005 Consegnato il 23 dic 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit initially of £60,000 credited to account designation number 36675547 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 dic 2005 Consegnato il 21 dic 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0