HCCAH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HCCAH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05096889 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HCCAH LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HCCAH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HCCAH LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED | 01 giu 2004 | 01 giu 2004 |
| TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED | 06 apr 2004 | 06 apr 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HCCAH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HCCAH LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per HCCAH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Alexander Burrell come amministratore in data 10 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 050968890008, creata il 12 giu 2014 | 91 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Geraldine Josephine Gallagher come amministratore in data 31 gen 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come amministratore in data 31 gen 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come segretario in data 31 gen 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 11 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 18 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 14 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Doubleday come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HCCAH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRELL, James Alexander | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 192486560001 | |||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | 185108770001 | |||||
| HUNTER, Gail Susan | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89557480002 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Amministratore | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| BENNISON, Matthew Edward | Segretario | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 161805270001 | |||||||
| DOUBLEDAY, Timothy | Segretario | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156121500001 | ||||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Segretario | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
| SOLOMAN, Sheila Margaret | Segretario | 5 The Green Hardingstone NN4 7BU Northampton Northamptonshire | British | 45253560008 | ||||||
| TRUSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| ANDERSON, Peter George | Amministratore | 23 Cheshire Road OX9 3LQ Thame Oxfordshire | British | 70304810001 | ||||||
| BELLONE, Norman Edward | Amministratore | Gardens Cottage Bagendon GL7 7DU Cirencester Gloucestershire | British | 126414070001 | ||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | 108534390002 | |||||
| DAY, Mark | Amministratore | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | 124446000001 | |||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Amministratore | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 91011320001 | |||||
| NISBETT, Paul Sandle | Amministratore | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | 132613500001 | |||||
| PEEKE, Alexander | Amministratore | 7 Milton Lodge Whitton Road TW1 1BU Twickenham | British | 98031180001 | ||||||
| STOKER, Louise Jane | Amministratore | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | 96079800001 | ||||||
| WHITE, Graham Peter | Amministratore | Copsem Lane KT22 0NT Oxshott Woodlands House Surrey | United Kingdom | British | 4934020002 | |||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Amministratore | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | 61053330001 |
HCCAH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 12 giu 2014 Consegnato il 18 giu 2014 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| English law deed of accession | Creato il 27 feb 2013 Consegnato il 01 mar 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 dic 2011 Consegnato il 10 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 18 giu 2007 Consegnato il 22 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 31 mar 2006 Consegnato il 06 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003 | Creato il 24 gen 2005 Consegnato il 02 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 18 dic 2003 Acquisito il 24 gen 2005 Consegnato il 27 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders | |
Brevi particolari Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 14 gen 2000 Acquisito il 24 gen 2005 Consegnato il 03 feb 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0