HCCAH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHCCAH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05096889
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HCCAH LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HCCAH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HCCAH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED01 giu 200401 giu 2004
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED06 apr 200406 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di HCCAH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HCCAH LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HCCAH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr James Alexander Burrell come amministratore in data 10 nov 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    1 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 050968890008, creata il 12 giu 2014

    91 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2014

    Stato del capitale al 07 apr 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mrs Geraldine Josephine Gallagher come amministratore in data 31 gen 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come amministratore in data 31 gen 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Edward Bennison come segretario in data 31 gen 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    1 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    18 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    14 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Edward Bennison come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy Doubleday come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HCCAH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Segretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Segretario nominato
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    Amministratore
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Amministratore
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    Amministratore
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    HCCAH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2014
    Consegnato il 18 giu 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    English law deed of accession
    Creato il 27 feb 2013
    Consegnato il 01 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2011
    Consegnato il 10 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 18 giu 2007
    Consegnato il 22 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    Creato il 24 gen 2005
    Consegnato il 02 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 02 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 2003
    Acquisito il 24 gen 2005
    Consegnato il 27 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    Brevi particolari
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 27 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 14 gen 2000
    Acquisito il 24 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'acquisizione (400)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0