NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED

NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05101382
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza per anziani e disabili (87300) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1110 Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MICHCO 406 LIMITED14 apr 200414 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al14 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Rehana Kousar il 28 nov 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sujahan Begum Jalil il 28 nov 2024

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2023

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2018

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sujahan Begum Jalil il 21 ago 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Rehana Kousar il 29 mar 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Rehana Kousar il 29 mar 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    9 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 mar 2018 al 30 giu 2018

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Andrew Gordon Lennox come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dawn Allyson Berry come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Rehana Kousar come amministratore in data 19 gen 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Sujahan Begum Jalil come amministratore in data 19 gen 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 21 Miller Court Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury Gloucestershire GL20 8DN a 1110 Elliott Court Coventry Business Park Coventry CV5 6UB in data 24 gen 2018

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JALIL, Sujahan Begum
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    Amministratore
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector159459470008
    KOUSAR, Rehana
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    Amministratore
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector240253740004
    BALCHIN, Ann Dorothy
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    Devon
    Segretario
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    Devon
    British60374330003
    KING, Paul Dennis Arthur
    Sedgemoor Cottage
    21 Main Road
    TA7 0EB Weston Zoy Land
    Bridgwater
    Segretario
    Sedgemoor Cottage
    21 Main Road
    TA7 0EB Weston Zoy Land
    Bridgwater
    BritishDirector97362330001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    Segretario
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    158305320001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    MH SECRETARIES LIMITED
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Segretario
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2893220
    39754020001
    MICHELMORES SECRETARIES LIMITED
    Woodwater House
    EX2 5WR Exeter
    Devon
    Segretario
    Woodwater House
    EX2 5WR Exeter
    Devon
    68750980001
    BALCHIN, Ann Dorothy
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    Devon
    Amministratore
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    Devon
    EnglandBritishDirector60374330003
    BALCHIN, Jack Wyatt
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    North Devon
    Amministratore
    Sealands
    New Barnstaple Road
    EX34 9NT Ilfracombe
    North Devon
    EnglandBritishDirector103285120001
    BERRY, Dawn Allyson
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    Amministratore
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer208169400001
    BUCHAN, William James
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79917240001
    BURTON, David
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Amministratore
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant236544840001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    DOUGLAS, James Barclay
    - 3
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    - 3
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritishCompany Director159117650001
    FAHY, John Douglas
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director159117670001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    KING, Paul Dennis Arthur
    Sedgemoor Cottage
    21 Main Road
    TA7 0EB Weston Zoy Land
    Bridgwater
    Amministratore
    Sedgemoor Cottage
    21 Main Road
    TA7 0EB Weston Zoy Land
    Bridgwater
    BritishCompany Director97362330001
    KIRKPATRICK, Paul
    17a Friary Road
    NG24 1LE Newark
    Friary House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    17a Friary Road
    NG24 1LE Newark
    Friary House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishChief Technical Officer124307020001
    LENNOX, Andrew Gordon
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    Amministratore
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    United KingdomBritishChief Executive185434680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MOSS, Paul Michael
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritishFinance Director1993340004
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    SCANDRETT, Barbara
    - 3
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    - 3
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    WalesBritishCeo161743730001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    YOUNG, Katrine Lilias
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Amministratore
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    UkBritishDirector172973980001
    MICHELMORES SECRETARIES LIMITED
    Woodwater House
    EX2 5WR Exeter
    Devon
    Amministratore
    Woodwater House
    EX2 5WR Exeter
    Devon
    68750980001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07604202
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NETWORKING CARE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 30 set 2011
    Consegnato il 13 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the acceding company and each other charging company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transazioni
    • 13 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 06 mag 2011
    Consegnato il 20 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land lying to the east of bernpark road teignmouth t/no DN155566,land on the west side of high street honiton t/no DN263892,5 high street honiton t/no DN87154 (for further details of property charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 27 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 27 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 27 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the north west side of gardenia 5 atlantic way westwood ho bideford (cherry tree) t/n DN516633 5 high street honiton t/n DN87154 and 37 thurlow road torquay (rose cottage/lavender manor) t/n DN89496 (for further properties charged please refer to form MG01) together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 27 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 22 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property land on the north side of gardenia 5 atlantic way westward ho! Bideford t/n DN457229. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All f/h property k/a land on the west side of high street honiton t/n DN263892 and f/h property k/a 5 high street honiton t/n DN8715437. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 2005
    Consegnato il 26 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37 thurlow road, torquay, devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43 canford avenue exmouth devon t/no DN186921. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    21 winter street paignton t/no DN233248. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 nov 2004
    Consegnato il 11 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 2004
    Consegnato il 11 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as land lying to the east side of barnpark road teignmouth and 8 barnpark road teignmouth,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0