CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05111485 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
- Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SHEPTON MALLET TREATMENT CENTRE LIMITED | 19 lug 2004 | 19 lug 2004 |
| SHEPTON MALLETT TREATMENT CENTRE LIMITED | 29 apr 2004 | 29 apr 2004 |
| EVER 2349 LIMITED | 26 apr 2004 | 26 apr 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Soddisfazione dell'onere 051114850005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Nomina di Mr Lee Stafford Gage come segretario in data 14 apr 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Jonathan David Calow come segretario in data 14 apr 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 05 ago 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 30 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 25 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore in data 25 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Michael Robert Parish come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Philip James Whitecross come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB a Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 06 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 31 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 30 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE, Lee Stafford | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 282066890001 | |||||||
| EASTON, James William | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 118320980001 | |||||
| STICKLAND, David George | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||
| CALNAN, Fiona Maria | Segretario | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | Irish | 57973740001 | ||||||
| CALOW, Jonathan David | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 176329710001 | |||||||
| HORWITZ, Belle | Segretario | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | 82932070001 | ||||||
| KITTOE, Stephen Maurice | Segretario | Southbourne Road BN22 8RE Eastbourne Lavender House, 255 East Sussex | British | 692590012 | ||||||
| O'MURCHU, Lorcan | Segretario | 31 Sea Way PO22 7RZ Middleton On Sea The Little House West Sussex | Irish | 139252620001 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Central Square South Orchard Street NE1 3XX Newcastle Upon Tyne | 60471940007 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
| ABUMRAD, Naji, Dr | Amministratore | 933 Travelers Ct Nashville Tennessee,Tn 37220 Usa | American | 99950770002 | ||||||
| BERGER, Laurence | Amministratore | 430 E 63rd Street Apt 9e New York New York 10021 Usa | American | 118067530001 | ||||||
| CALNAN, Fiona Maria | Amministratore | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | England | Irish | 57973740001 | |||||
| HORWITZ, Belle | Amministratore | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | 82932070001 | ||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||
| ISSACS, Timothy Keith | Amministratore | 4 Raeburn Close NW11 6UE London | British | 101555530001 | ||||||
| KITTOE, Nicholas Benedict Montagu | Amministratore | Flat 1 355 Clapham Road SW9 9BT London | United Kingdom | British | 1852680004 | |||||
| KLEIN, Arthur, Dr | Amministratore | 515 E. 79 St. Apt. 12a New York New York 10021 Usa | American | 106464770001 | ||||||
| MORRISON, David John | Amministratore | Albert Bridge Road SW11 4PX London 21 | British | 29500910001 | ||||||
| O'MURCHU, Lorcan | Amministratore | 31 Sea Way PO22 7RZ Middleton On Sea The Little House West Sussex | United Kingdom | Irish | 139252620001 | |||||
| PARISH, Michael Robert | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 78828750003 | |||||
| PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 151240810001 | |||||
| ROBINSKI, Katarzyna Maria | Amministratore | 46 Sutherland Place W2 5BY London | United Kingdom | British | 141565370001 | |||||
| WEINER, Jonathan | Amministratore | 269 Haviland Road Stamford Connecticut Ct 06903 United States | United Kingdom | American | 82931980001 | |||||
| WHITECROSS, Philip James | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 193730760001 | |||||
| WHITESIDE, Paul Andrew James | Amministratore | 10 Barnsdale LE16 8SG Great Easton Leicestershire | England | British | 100247150001 | |||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice Plus Group Uksh Limited | 06 apr 2016 | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 26 set 2014 Consegnato il 01 ott 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security assignment | Creato il 11 ago 2006 Consegnato il 19 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All its right title interest and benefit in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental account charge | Creato il 18 ott 2005 Consegnato il 21 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The chargor charges the supplemental security assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 19 ago 2004 Consegnato il 01 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All estates or interests in any f/h or l/h property, all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery on that property and the benefit of any covenants for title, all plant and machinery, all rights of any amount standing to the credit of the rent proceeds account and all rights in respect of the project documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 19 ago 2004 Consegnato il 01 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The security assets (being all monies from time to time standing to the credit of the security accounts). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0