CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED

CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05111485
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    • Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hawker House 5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHEPTON MALLET TREATMENT CENTRE LIMITED19 lug 200419 lug 2004
    SHEPTON MALLETT TREATMENT CENTRE LIMITED29 apr 200429 apr 2004
    EVER 2349 LIMITED26 apr 200426 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 051114850005 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Lee Stafford Gage come segretario in data 14 apr 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan David Calow come segretario in data 14 apr 2021

    1 pagineTM02

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 05 ago 2020

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Care Uk (Uksh) Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 25 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Robert Parish come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip James Whitecross come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB a Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 06 nov 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAGE, Lee Stafford
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Segretario
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    282066890001
    EASTON, James William
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish118320980001
    STICKLAND, David George
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish130704670001
    CALNAN, Fiona Maria
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Irish57973740001
    CALOW, Jonathan David
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Segretario
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    176329710001
    HORWITZ, Belle
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    Segretario
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    American82932070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    Segretario
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    British692590012
    O'MURCHU, Lorcan
    31 Sea Way
    PO22 7RZ Middleton On Sea
    The Little House
    West Sussex
    Segretario
    31 Sea Way
    PO22 7RZ Middleton On Sea
    The Little House
    West Sussex
    Irish139252620001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    60471940007
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ABUMRAD, Naji, Dr
    933 Travelers Ct
    Nashville
    Tennessee,Tn 37220
    Usa
    Amministratore
    933 Travelers Ct
    Nashville
    Tennessee,Tn 37220
    Usa
    American99950770002
    BERGER, Laurence
    430 E 63rd Street
    Apt 9e
    New York
    New York 10021
    Usa
    Amministratore
    430 E 63rd Street
    Apt 9e
    New York
    New York 10021
    Usa
    American118067530001
    CALNAN, Fiona Maria
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    EnglandIrish57973740001
    HORWITZ, Belle
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    Amministratore
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    American82932070001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    ISSACS, Timothy Keith
    4 Raeburn Close
    NW11 6UE London
    Amministratore
    4 Raeburn Close
    NW11 6UE London
    British101555530001
    KITTOE, Nicholas Benedict Montagu
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    Amministratore
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    United KingdomBritish1852680004
    KLEIN, Arthur, Dr
    515 E. 79 St. Apt. 12a
    New York
    New York 10021
    Usa
    Amministratore
    515 E. 79 St. Apt. 12a
    New York
    New York 10021
    Usa
    American106464770001
    MORRISON, David John
    Albert Bridge Road
    SW11 4PX London
    21
    Amministratore
    Albert Bridge Road
    SW11 4PX London
    21
    British29500910001
    O'MURCHU, Lorcan
    31 Sea Way
    PO22 7RZ Middleton On Sea
    The Little House
    West Sussex
    Amministratore
    31 Sea Way
    PO22 7RZ Middleton On Sea
    The Little House
    West Sussex
    United KingdomIrish139252620001
    PARISH, Michael Robert
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish151240810001
    ROBINSKI, Katarzyna Maria
    46 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Amministratore
    46 Sutherland Place
    W2 5BY London
    United KingdomBritish141565370001
    WEINER, Jonathan
    269 Haviland Road
    Stamford
    Connecticut Ct 06903
    United States
    Amministratore
    269 Haviland Road
    Stamford
    Connecticut Ct 06903
    United States
    United KingdomAmerican82931980001
    WHITECROSS, Philip James
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish193730760001
    WHITESIDE, Paul Andrew James
    10 Barnsdale
    LE16 8SG Great Easton
    Leicestershire
    Amministratore
    10 Barnsdale
    LE16 8SG Great Easton
    Leicestershire
    EnglandBritish100247150001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Practice Plus Group Uksh Limited
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione05111488
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 set 2014
    Consegnato il 01 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transazioni
    • 01 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 11 ago 2006
    Consegnato il 19 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title interest and benefit in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental account charge
    Creato il 18 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor charges the supplemental security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Health
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 19 ago 2004
    Consegnato il 01 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All estates or interests in any f/h or l/h property, all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery on that property and the benefit of any covenants for title, all plant and machinery, all rights of any amount standing to the credit of the rent proceeds account and all rights in respect of the project documents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Summit Asset Management Limited
    Transazioni
    • 01 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account charge
    Creato il 19 ago 2004
    Consegnato il 01 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The security assets (being all monies from time to time standing to the credit of the security accounts). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Health
    Transazioni
    • 01 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0