PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05111488 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
- Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARE UK (UKSH) LIMITED | 22 mag 2013 | 22 mag 2013 |
| UK SPECIALIST HOSPITALS LIMITED | 27 gen 2005 | 27 gen 2005 |
| UK SPECIALITY HOSPITALS LIMITED | 29 apr 2004 | 29 apr 2004 |
| EVER 2348 LIMITED | 26 apr 2004 | 26 apr 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Nomina di Mr Lee Stafford Gage come segretario in data 14 apr 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan David Calow come segretario in data 14 apr 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 05 ago 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 25 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore in data 25 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Robert Parish come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip James Whitecross come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB a Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 06 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 18 lug 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 26 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE, Lee Stafford | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 282066910001 | |||||||
| EASTON, James William | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 118320980001 | |||||
| STICKLAND, David George | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||
| CALNAN, Fiona Maria | Segretario | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | Irish | 57973740001 | ||||||
| CALOW, Jonathan David | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 176309300001 | |||||||
| HORWITZ, Belle | Segretario | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | 82932070001 | ||||||
| KITTOE, Stephen Maurice | Segretario | Southbourne Road BN22 8RE Eastbourne Lavender House, 255 East Sussex | British | 692590012 | ||||||
| O'MURCHU, Lorcan | Segretario | Castle Road YO11 1NY Scarborough 150 | Irish | 138020270001 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Central Square South Orchard Street NE1 3XX Newcastle Upon Tyne | 60471940007 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
| ABUMRAD, Naji, Dr | Amministratore | 933 Travelers Ct Nashville Tennessee,Tn 37220 Usa | American | 99950770002 | ||||||
| CALNAN, Fiona Maria | Amministratore | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | England | Irish | 57973740001 | |||||
| HORWITZ, Belle | Amministratore | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | 82932070001 | ||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||
| ISAACS, Timothy Keith | Amministratore | 4 Raeburn Close NW11 6UE London | United Kingdom | British | 64871070001 | |||||
| KITTOE, Nicholas Benedict Montagu | Amministratore | Flat 1 355 Clapham Road SW9 9BT London | United Kingdom | British | 1852680004 | |||||
| KITTOE, Nicholas Benedict Montagu | Amministratore | Flat 1 355 Clapham Road SW9 9BT London | United Kingdom | British | 1852680004 | |||||
| MORRISON, David John | Amministratore | 904 Drake House Dolphin Square SW1V 3NW London | United Kingdom | British | 29500910002 | |||||
| O'MURCHU, Lorcan | Amministratore | Castle Road YO11 1NY Scarborough 150 | Irish | 138020270001 | ||||||
| PARISH, Michael Robert | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 78828750003 | |||||
| PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 151240810001 | |||||
| ROBINSKI, Katarzyna Maria | Amministratore | 46 Sutherland Place W2 5BY London | United Kingdom | British | 141565370001 | |||||
| WEINER, Jonathan | Amministratore | 269 Haviland Road Stamford Connecticut Ct 06903 United States | United Kingdom | American | 82931980001 | |||||
| WHITECROSS, Philip James | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 193730760001 | |||||
| WHITESIDE, Paul Andrew James | Amministratore | 10 Barnsdale LE16 8SG Great Easton Leicestershire | England | British | 100247150001 | |||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice Plus Group Hospitals Limited | 06 apr 2016 | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 10 set 2008 Consegnato il 16 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £7,998 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed charge all its interest in an interest bearing instant access deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security assignment | Creato il 31 lug 2008 Consegnato il 04 ago 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right title interest and benefit present and future in and to the assigned property being right title and interest in and to amounts payable by uksh south west limited to the assignor pursuant to a lease. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 08 mar 2007 Consegnato il 15 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property k/a part of emerald's park emersons green bristol avon t/no AV253243. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 05 feb 2007 Consegnato il 10 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 apr 2005 Consegnato il 20 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £7,998 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari The rents or other monies including interest payable. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creato il 14 feb 2005 Consegnato il 04 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re UK specialist hospitals limited and numbered 02863205 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0