PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED

PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05111488
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    • Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hawker House 5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARE UK (UKSH) LIMITED22 mag 201322 mag 2013
    UK SPECIALIST HOSPITALS LIMITED27 gen 200527 gen 2005
    UK SPECIALITY HOSPITALS LIMITED 29 apr 200429 apr 2004
    EVER 2348 LIMITED26 apr 200426 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Lee Stafford Gage come segretario in data 14 apr 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan David Calow come segretario in data 14 apr 2021

    1 pagineTM02

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020

    2 paginePSC05

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name02 ott 2020

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 set 2020

    RES15

    Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 05 ago 2020

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    25 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Care Uk Clinical Services Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 25 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Robert Parish come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip James Whitecross come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB a Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 06 nov 2019

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 lug 2019

    • Capitale: GBP 0.10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Shares divided 27/06/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAGE, Lee Stafford
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Segretario
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    282066910001
    EASTON, James William
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish118320980001
    STICKLAND, David George
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish130704670001
    CALNAN, Fiona Maria
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Irish57973740001
    CALOW, Jonathan David
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Segretario
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    176309300001
    HORWITZ, Belle
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    Segretario
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    American82932070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    Segretario
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    British692590012
    O'MURCHU, Lorcan
    Castle Road
    YO11 1NY Scarborough
    150
    Segretario
    Castle Road
    YO11 1NY Scarborough
    150
    Irish138020270001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    60471940007
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ABUMRAD, Naji, Dr
    933 Travelers Ct
    Nashville
    Tennessee,Tn 37220
    Usa
    Amministratore
    933 Travelers Ct
    Nashville
    Tennessee,Tn 37220
    Usa
    American99950770002
    CALNAN, Fiona Maria
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    47 Mallard Place
    Strawberry Vale
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    EnglandIrish57973740001
    HORWITZ, Belle
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    Amministratore
    6 West 77 Street
    New York
    New York 10024
    United States
    American82932070001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    ISAACS, Timothy Keith
    4 Raeburn Close
    NW11 6UE London
    Amministratore
    4 Raeburn Close
    NW11 6UE London
    United KingdomBritish64871070001
    KITTOE, Nicholas Benedict Montagu
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    Amministratore
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    United KingdomBritish1852680004
    KITTOE, Nicholas Benedict Montagu
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    Amministratore
    Flat 1
    355 Clapham Road
    SW9 9BT London
    United KingdomBritish1852680004
    MORRISON, David John
    904 Drake House Dolphin Square
    SW1V 3NW London
    Amministratore
    904 Drake House Dolphin Square
    SW1V 3NW London
    United KingdomBritish29500910002
    O'MURCHU, Lorcan
    Castle Road
    YO11 1NY Scarborough
    150
    Amministratore
    Castle Road
    YO11 1NY Scarborough
    150
    Irish138020270001
    PARISH, Michael Robert
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish151240810001
    ROBINSKI, Katarzyna Maria
    46 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Amministratore
    46 Sutherland Place
    W2 5BY London
    United KingdomBritish141565370001
    WEINER, Jonathan
    269 Haviland Road
    Stamford
    Connecticut Ct 06903
    United States
    Amministratore
    269 Haviland Road
    Stamford
    Connecticut Ct 06903
    United States
    United KingdomAmerican82931980001
    WHITECROSS, Philip James
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    5-6 Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish193730760001
    WHITESIDE, Paul Andrew James
    10 Barnsdale
    LE16 8SG Great Easton
    Leicestershire
    Amministratore
    10 Barnsdale
    LE16 8SG Great Easton
    Leicestershire
    EnglandBritish100247150001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Practice Plus Group Hospitals Limited
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    5-6 Napier Court
    Napier Road
    RG1 8BW Reading
    Hawker House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione03462881
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PRACTICE PLUS GROUP UKSH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 10 set 2008
    Consegnato il 16 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,998 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all its interest in an interest bearing instant access deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Gm Investment Trustees Limited and Gm (UK) Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 16 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 31 lug 2008
    Consegnato il 04 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title interest and benefit present and future in and to the assigned property being right title and interest in and to amounts payable by uksh south west limited to the assignor pursuant to a lease. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 08 mar 2007
    Consegnato il 15 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a part of emerald's park emersons green bristol avon t/no AV253243. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 feb 2007
    Consegnato il 10 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 apr 2005
    Consegnato il 20 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,998 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The rents or other monies including interest payable.
    Persone aventi diritto
    • Gm Investment Trustees Limited and Gm (UK) Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 14 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re UK specialist hospitals limited and numbered 02863205 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0