PENELLY PROPERTIES LIMITED

PENELLY PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPENELLY PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05112218
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tanners House
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Cumbria
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2020 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Cessazione di Paul Anthony Chesham come persona con controllo significativo il 19 ago 2019

    1 paginePSC07

    Cessazione di Andrew Charles Peill come persona con controllo significativo il 19 ago 2019

    1 paginePSC07

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    3 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    38 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sub division 19/08/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2018 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    4 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    36 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Moore and Smalley Llp Richard House Winckley Square Preston Lancashire PR1 3HP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Moore and Smalley Llp Richard House Winckley Square Preston Lancashire PR1 3HP

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2016

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2016

    Stato del capitale al 06 mag 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2015

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEILL, Andrew Charles
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    Segretario
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    BritishDirector2095530002
    CHESHAM, Paul Anthony
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    EnglandBritishDirector98713540001
    PEILL, Andrew Charles
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    England
    EnglandBritishDirector2095530002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Paul Anthony Chesham
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    06 apr 2016
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr Andrew Charles Peill
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    06 apr 2016
    Gulfs Road
    LA9 4DT Kendal
    Tanners House
    Cumbria
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PENELLY PROPERTIES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    18 set 2019La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PENELLY PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture and legal charge
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 31 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37 tape street cheadle, 33 tape street cheadle and 12 holt lane kingsley staffordshire fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cumberland Building Society
    Transazioni
    • 31 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 high street, neston. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    74/76 telegraph road, heswall. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20 high street, sandbach, cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 higher road, urmston and land at rear of 3 higher road, urmston. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 high street, whitchurch. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    76 and 78 station road, ainsdale. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 17 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    86-88 wallasey road wallasey t/no CH81944. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    76 high street pwllheli t/no WA531558,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0