BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED

BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05113820
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Office 16 Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLANCCO TECHNOLOGY GROUP PLC05 apr 201605 apr 2016
    REGENERSIS PLC04 mar 200804 mar 2008
    FONEBAK PLC13 gen 200513 gen 2005
    FONEBAK LIMITED26 ott 200426 ott 2004
    FONEBAK GROUP LIMITED07 set 200407 set 2004
    BROOMCO (3469) LIMITED27 apr 200427 apr 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al27 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma11 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al27 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Rocco Louis Difruscio come amministratore in data 01 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Craig Jones come amministratore in data 01 dic 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2024 con aggiornamenti

    234 pagineCS01

    Notifica di White Bidco Limited come persona con controllo significativo il 30 ott 2023

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 28 mar 2024

    2 paginePSC09

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2023

    95 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 051138200017 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da , Suite 1, Chapel House Start Hill, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM22 7WE, England a Office 16 Thremhall Park Start Hill Bishop’S Stortford Hertfordshire CM22 7WE in data 07 mar 2024

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 051138200018, creata il 19 gen 2024

    45 pagineMR01

    Cessazione della carica di Lorraine Young Company Secretaries Limited come segretario in data 31 dic 2023

    1 pagineTM02

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    9 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata

    1 pagineRR02

    Nomina di Satoru Johan Ogawa come amministratore in data 17 nov 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Adam Paul Moloney come amministratore in data 17 nov 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Stanley Lawrence Woodward come amministratore in data 17 nov 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Frank Blin come amministratore in data 17 nov 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Catherine Elisa Michel come amministratore in data 17 nov 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Kevin Skelton come amministratore in data 17 nov 2023

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 ott 2023

    • Capitale: GBP 1,551,491.98
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2022

    124 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 ott 2022

    • Capitale: GBP 1,514,197.14
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DIFRUSCIO, Rocco Louis
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanCeo331063720001
    OGAWA, Satoru Johan
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanCfo316674540001
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Segretario
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    BritishFinance Director79797070001
    GILBERT, David Samuel
    119 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    119 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector107081840001
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Segretario
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WEATHERALL, Sally
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    152389600001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Seabrook Road
    TN10 3AS Tonbridge
    13
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Seabrook Road
    TN10 3AS Tonbridge
    13
    Kent
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7873246
    165261700001
    PRISM COSEC LIMITED
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Segretario
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05533248
    116519070002
    BLIN, Frank
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector193170420003
    BRADSHAW, Kevin Michael
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director124019940001
    BUTCHER, Keith
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director295528240001
    CLAWSON, Pat Joseph
    Rainwater Drive, Suite 100
    Alpharetta
    30009 Fulton County
    11675
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    Rainwater Drive, Suite 100
    Alpharetta
    30009 Fulton County
    11675
    Georgia
    Usa
    United StatesAmericanChief Executive Officer119383320001
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Amministratore
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    EnglandBritishFinance Director79797070001
    DHODY, Jog
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant104269910005
    GILBERT, David Samuel
    119 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    119 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector107081840001
    HERRICK, Simon Edward
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCfo70414940003
    HEWITT, Jeffrey Lindsey
    Palo Alto
    6 College Way
    HA6 2BL Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Palo Alto
    6 College Way
    HA6 2BL Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector3302250001
    HOLLAND, David Alan
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    Amministratore
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    EnglandBritishDirector97792830001
    JONES, Matthew Craig
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop’S Stortford
    Office 16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanCeo244753750001
    KELHAM, David William
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone159105430001
    MICHEL, Catherine Elisa
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    EnglandAmericanCto322953130001
    MOLONEY, Adam Paul
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCfo242307590002
    PEACOCK, Matthew Roy
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    ItalyBritishNone104718150001
    PEACOCK, Michael William
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone158374710002
    POWELL, Ian Donald
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    Amministratore
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    EnglandBritishChief Executive Officer37804490002
    ROGERSON, Philip Graham
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director227032820001
    RUSSELL, Thomas Alexander
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone147025270001
    SHIELDS, Gordon Sydney
    31 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    31 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishDirector10499730002
    SHIELDS, Stephen Andrew
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishDirector107406090001
    SKELTON, Thomas Kevin
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Suite 1, Chapel House
    Hertfordshire
    England
    United StatesAmericanCheif Executive Officer201629370001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive Officer71396660002
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hichingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Kingfisher Way
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hichingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Kingfisher Way
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector151756520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Office 16
    United Kingdom
    30 ott 2023
    Thremhall Park
    Start Hill
    CM22 7WE Bishop's Stortford
    Office 16
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione15030572
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 lug 201730 ott 2023La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 gen 2024
    Consegnato il 22 gen 2024
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kroll Trustee Services Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2021
    Consegnato il 29 gen 2021
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mar 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 dic 2013
    Consegnato il 20 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 20 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 dic 2013
    Consegnato il 19 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 19 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2013
    Consegnato il 06 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2013
    Consegnato il 29 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 lug 2013
    Consegnato il 17 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Novated pledge on shares agreement
    Creato il 31 gen 2012
    Consegnato il 15 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to the chargee and/or the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A moveable mortgage over the charged shares being the shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge on shares agreement
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 21 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    As security for the complete satisfaction of any and all secured obligations up to the secured amount a first ranking security over the charged shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2011
    Consegnato il 19 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 19 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge on shares agreement
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 17 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    320 shares with a nominal value of ron 10.00 each and any and all shares in the share capital of regeneris srl see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv
    Transazioni
    • 17 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of pledge
    Creato il 03 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured assets being the existing shares the further shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A mortgage over securities
    Creato il 12 giu 2008
    Consegnato il 01 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv the Security Trustee
    Transazioni
    • 01 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2008
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv, as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A legal mortgage over securities
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 28 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the shares, the crest rights and the dividends.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv Acting in Its Capacity as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 08 feb 2005
    Consegnato il 09 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The £250,000 life cover policy dated 1 decmebr 2004 in respect of kathleen woodward held with halifax life limited policy no ASSH019494 and the £250,000 life cover and £250,000 critical illness cover policy dated 7 december 2004 in respect of stephen shields held with halifax life limited with policy no ASSH19495 the policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the assignors whole right title and interest in the policies.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 24 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Security Trustee
    Transazioni
    • 24 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0