BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05113820 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Office 16 Thremhall Park Start Hill CM22 7WE Bishop’S Stortford Hertfordshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP PLC | 05 apr 2016 | 05 apr 2016 |
REGENERSIS PLC | 04 mar 2008 | 04 mar 2008 |
FONEBAK PLC | 13 gen 2005 | 13 gen 2005 |
FONEBAK LIMITED | 26 ott 2004 | 26 ott 2004 |
FONEBAK GROUP LIMITED | 07 set 2004 | 07 set 2004 |
BROOMCO (3469) LIMITED | 27 apr 2004 | 27 apr 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 27 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 11 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 27 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Rocco Louis Difruscio come amministratore in data 01 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Craig Jones come amministratore in data 01 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2024 con aggiornamenti | 234 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Notifica di White Bidco Limited come persona con controllo significativo il 30 ott 2023 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 28 mar 2024 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2023 | 95 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 051138200017 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Suite 1, Chapel House Start Hill, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM22 7WE, England a Office 16 Thremhall Park Start Hill Bishop’S Stortford Hertfordshire CM22 7WE in data 07 mar 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 051138200018, creata il 19 gen 2024 | 45 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Lorraine Young Company Secretaries Limited come segretario in data 31 dic 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT10 | ||||||||||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 9 pagine | MAR | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 1 pagine | RR02 | ||||||||||||||||||
Nomina di Satoru Johan Ogawa come amministratore in data 17 nov 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Adam Paul Moloney come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Stanley Lawrence Woodward come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Frank Blin come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Elisa Michel come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Kevin Skelton come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 ott 2023
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2022 | 124 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 ott 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFRUSCIO, Rocco Louis | Amministratore | Thremhall Park Start Hill CM22 7WE Bishop’S Stortford Office 16 Hertfordshire United Kingdom | United States | American | Ceo | 331063720001 | ||||||||
OGAWA, Satoru Johan | Amministratore | Thremhall Park Start Hill CM22 7WE Bishop’S Stortford Office 16 Hertfordshire United Kingdom | United States | American | Cfo | 316674540001 | ||||||||
CROCKER, Arthur Rupert | Segretario | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | British | Finance Director | 79797070001 | |||||||||
GILBERT, David Samuel | Segretario | 119 Gregories Road HP9 1HZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 107081840001 | |||||||||
TEMPLE, John Nicholas | Segretario | Windfalls Highfield Road West Moors BH22 0NA Ferndown Dorset | British | 84493950001 | ||||||||||
WEATHERALL, Sally | Segretario | 4 Elm Place Old Witney Road Eynsham OX29 4BD Witney Oxfordshire | 152389600001 | |||||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||
LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Seabrook Road TN10 3AS Tonbridge 13 Kent United Kingdom |
| 165261700001 | ||||||||||
PRISM COSEC LIMITED | Segretario | 10 Margaret Street W1W 8RL London Prism Cosec United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
BLIN, Frank | Amministratore | Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Suite 1, Chapel House Hertfordshire England | United Kingdom | British | Director | 193170420003 | ||||||||
BRADSHAW, Kevin Michael | Amministratore | 32 Wigmore Street W1U 2RP London 4th Floor United Kingdom | England | British | Managing Director | 124019940001 | ||||||||
BUTCHER, Keith | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | England | British | Finance Director | 295528240001 | ||||||||
CLAWSON, Pat Joseph | Amministratore | Rainwater Drive, Suite 100 Alpharetta 30009 Fulton County 11675 Georgia Usa | United States | American | Chief Executive Officer | 119383320001 | ||||||||
CROCKER, Arthur Rupert | Amministratore | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | England | British | Finance Director | 79797070001 | ||||||||
DHODY, Jog | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 104269910005 | ||||||||
GILBERT, David Samuel | Amministratore | 119 Gregories Road HP9 1HZ Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Director | 107081840001 | ||||||||
HERRICK, Simon Edward | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | England | British | Cfo | 70414940003 | ||||||||
HEWITT, Jeffrey Lindsey | Amministratore | Palo Alto 6 College Way HA6 2BL Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 3302250001 | ||||||||
HOLLAND, David Alan | Amministratore | The Chestnuts Long Green, Wortham IP22 1RD Diss Norfolk | England | British | Director | 97792830001 | ||||||||
JONES, Matthew Craig | Amministratore | Thremhall Park Start Hill CM22 7WE Bishop’S Stortford Office 16 Hertfordshire United Kingdom | United States | American | Ceo | 244753750001 | ||||||||
KELHAM, David William | Amministratore | 4 Elm Place Old Witney Road Eynsham OX29 4BD Witney Oxfordshire | England | British | Director | 87146390001 | ||||||||
KELHAM, David William | Amministratore | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | Finance Director | 87146390001 | ||||||||
LEE, Andrew Stephen | Amministratore | Kingfisher Way Hinchingbrooke Business Park PE29 6FN Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | None | 159105430001 | ||||||||
MICHEL, Catherine Elisa | Amministratore | Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Suite 1, Chapel House Hertfordshire England | England | American | Cto | 322953130001 | ||||||||
MOLONEY, Adam Paul | Amministratore | Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Suite 1, Chapel House Hertfordshire England | United Kingdom | British | Cfo | 242307590002 | ||||||||
PEACOCK, Matthew Roy | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | Italy | British | None | 104718150001 | ||||||||
PEACOCK, Michael William | Amministratore | 32 Wigmore Street W1U 2RP London 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | None | 158374710002 | ||||||||
POWELL, Ian Donald | Amministratore | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent | England | British | Chief Executive Officer | 37804490002 | ||||||||
ROGERSON, Philip Graham | Amministratore | Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Suite 1, Chapel House Hertfordshire England | United Kingdom | British | Company Director | 227032820001 | ||||||||
RUSSELL, Thomas Alexander | Amministratore | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | None | 147025270001 | ||||||||
SHIELDS, Gordon Sydney | Amministratore | 31 Thorpe Esplanade SS1 3BA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Director | 10499730002 | ||||||||
SHIELDS, Stephen Andrew | Amministratore | 32 The Broadway Thorp Bay SS1 3HJ Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Director | 107406090001 | ||||||||
SKELTON, Thomas Kevin | Amministratore | Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Suite 1, Chapel House Hertfordshire England | United States | American | Cheif Executive Officer | 201629370001 | ||||||||
STOKES, Gary Martin | Amministratore | 16a Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham West Midlands | England | British | Chief Executive Officer | 71396660002 | ||||||||
WILSON, Jeremy Michael Charles | Amministratore | Hichingbrooke Business Park PE29 6FN Huntingdon Kingfisher Way Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Director | 151756520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Bidco Limited | 30 ott 2023 | Thremhall Park Start Hill CM22 7WE Bishop's Stortford Office 16 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
24 lug 2017 | 30 ott 2023 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 19 gen 2024 Consegnato il 22 gen 2024 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 27 gen 2021 Consegnato il 29 gen 2021 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 10 dic 2013 Consegnato il 20 dic 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 04 dic 2013 Consegnato il 19 dic 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 23 ott 2013 Consegnato il 06 nov 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 23 ott 2013 Consegnato il 29 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 09 lug 2013 Consegnato il 17 lug 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Novated pledge on shares agreement | Creato il 31 gen 2012 Consegnato il 15 feb 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to the chargee and/or the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari A moveable mortgage over the charged shares being the shares and the related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge on shares agreement | Creato il 19 mag 2011 Consegnato il 21 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari As security for the complete satisfaction of any and all secured obligations up to the secured amount a first ranking security over the charged shares see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mag 2011 Consegnato il 19 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge on shares agreement | Creato il 30 giu 2010 Consegnato il 17 lug 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 320 shares with a nominal value of ron 10.00 each and any and all shares in the share capital of regeneris srl see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of pledge | Creato il 03 set 2009 Consegnato il 15 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The secured assets being the existing shares the further shares and the related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A mortgage over securities | Creato il 12 giu 2008 Consegnato il 01 lug 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares and the dividends see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 set 2007 Consegnato il 27 set 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 feb 2007 Consegnato il 09 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A legal mortgage over securities | Creato il 14 dic 2006 Consegnato il 28 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed charge the shares, the crest rights and the dividends. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of keyman policy | Creato il 08 feb 2005 Consegnato il 09 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The £250,000 life cover policy dated 1 decmebr 2004 in respect of kathleen woodward held with halifax life limited policy no ASSH019494 and the £250,000 life cover and £250,000 critical illness cover policy dated 7 december 2004 in respect of stephen shields held with halifax life limited with policy no ASSH19495 the policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the assignors whole right title and interest in the policies. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 set 2004 Consegnato il 24 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0