SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED

SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05118500
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORPORATE CENTRES NOMINEE LIMITED08 giu 200408 giu 2004
    SHELFCO (NO.2962) LIMITED04 mag 200404 mag 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13
    A7F24TKY

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X76N5REH

    Indirizzo della sede legale modificato da St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS in data 23 mag 2018

    2 pagineAD01
    A75C4WHS

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01
    A75C4WHC

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600
    A75C4WH4

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 mag 2018

    LRESSP

    Nomina di Miss Sarah Jane Williams come amministratore in data 28 mar 2018

    2 pagineAP01
    X734HQVE

    Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 28 mar 2018

    2 pagineAP01
    X734HQT5

    Cessazione della carica di Julian Miles Cobourne come amministratore in data 28 mar 2018

    1 pagineTM01
    X733I1MG

    Cessazione della carica di Nicholas Tebbutt come amministratore in data 28 mar 2018

    1 pagineTM01
    X733I1FT

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Tebbutt il 19 mar 2018

    2 pagineCH01
    X722OTFF

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA
    A6FD8MJ6

    Cessazione della carica di Catherine Jane Mccall come amministratore in data 28 lug 2017

    1 pagineTM01
    X6BSTJ9M

    Nomina di Mr. Nicholas Tebbutt come amministratore in data 18 lug 2017

    2 pagineAP01
    X6B4LAGO

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    X66IDMAZ

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Catherine Jane Mccall il 23 gen 2017

    2 pagineCH01
    X5ZC1BY9

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Miles Cobourne il 16 gen 2017

    2 pagineCH01
    X5YYVWFT

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Poultry London EC2R 8EJ a St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ in data 19 dic 2016

    1 pagineAD01
    X5M5BNZS

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA
    A5EMI69G

    Nomina di Ms Catherine Jane Mccall come amministratore in data 15 lug 2016

    2 pagineAP01
    X5CJETQA

    Cessazione della carica di Jonathan Edwin Ashcroft come amministratore in data 15 lug 2016

    1 pagineTM01
    X5CJETUA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 giu 2016

    Stato del capitale al 02 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X588TN0Z

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA
    L4GW63N4

    Cessazione della carica di Ian Bryan Womack come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01
    X4ATD0CW

    Chi sono gli amministratori di SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2084205
    1278390004
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89567200001
    WILLIAMS, Sarah Jane
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    EnglandBritishChartered Secretary126289610002
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario nominato
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023740001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    United KingdomBritishChartered Surveyor131434980001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritishAsset Manager198725060001
    ELLIS, Philip Frederick
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    United KingdomBritishCompany Director75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Amministratore
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritishCompany Director32807790002
    JONES, Richard Peter
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    EnglandBritishCompany Director76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    United KingdomBritishCompany Director198871760001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Amministratore
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritishCompany Director73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    United KingdomIrishFund Manager124787300002
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant228645590002
    WISE, David Andrew
    5 Orchid Grange Orchid Road
    Southgate
    N14 5HH London
    Amministratore
    5 Orchid Grange Orchid Road
    Southgate
    N14 5HH London
    BritishCompany Director74016310002
    WOMACK, Ian Bryan
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    1
    EnglandBritishCompany Director33902000006
    MIKJON LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Amministratore delegato nominato
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023730001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Serviced Offices Uk Gp Limited
    Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    England
    06 apr 2016
    Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies
    Numero di registrazione4063878
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 08 dic 2008
    Consegnato il 16 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 45-48 inclusive) swallow street birmingham t/no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a the golden eagle corner if hill street and swallow street birmingham t/no WM389526 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 19 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SERVICED OFFICES UK NOMINEE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mag 2018Inizio della liquidazione
    03 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0