SENSUSTECH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSENSUSTECH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05128216
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SENSUSTECH LIMITED?

    • (6420) /

    Dove si trova SENSUSTECH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SENSUSTECH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OVAL (1981) LIMITED14 mag 200414 mag 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di SENSUSTECH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per SENSUSTECH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 gen 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 gen 2011

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Mazars Llp Lancaster House 67 Newhall Street Birmingham B3 1NG in data 07 ott 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da The Barlands London Road Cheltenham Gloucestershire GL52 6UT in data 15 feb 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 gen 2010

    LRESSP

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    18 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    16 pagineAA

    legacy

    4 pagine395

    Chi sono gli amministratori di SENSUSTECH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Segretario
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    CARRUTHERS, William
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    United KingdomBritishOperations Director72325990001
    FISHER, Robert, Dr
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector116981620001
    MURPHY, Paul
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    British87441240001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    DICK, Callum Andrew John
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Amministratore
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    EnglandBritishDirector118924270001
    DOST, Parminder Pal Singh
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector87287360001
    LADKI, Malek
    The Retreat
    Friary Road, Portishead
    BS20 6LW Bristol
    Avon
    Amministratore
    The Retreat
    Friary Road, Portishead
    BS20 6LW Bristol
    Avon
    BritishDirector67399990001
    MURPHY, Paul
    117a Eleanor Road
    Prenton
    CH43 7QP Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    117a Eleanor Road
    Prenton
    CH43 7QP Wirral
    Merseyside
    BritishAccountant106665280001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001

    SENSUSTECH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 18 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 30 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 24 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee for Each of the Finance Parties) (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 24 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to an omnibus and set-off agreement supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 30 april 2004
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 24 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any one or more of the existing companies and any other further company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 17 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as oval (1981) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alan Dick & Company Limited
    Transazioni
    • 17 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SENSUSTECH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 gen 2010Inizio della liquidazione
    08 ago 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alistair Steven Wood
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Simon David Chandler
    6 Dominus Way
    Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    6 Dominus Way
    Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0