ORCHID8 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàORCHID8 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05135919
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ORCHID8 LIMITED?

    • Altre attività delle agenzie di collocamento (78109) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ORCHID8 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ORCHID8 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OUTSAUCE CONTRACTING LIMITED05 dic 201205 dic 2012
    ORIEL CONTRACTORS LIMITED02 apr 200702 apr 2007
    ORIEL COMPOSITES LIMITED24 mag 200424 mag 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di ORCHID8 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ORCHID8 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2020

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2019

    18 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2018

    33 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da St Georges House 13-14 Ambrose Street Cheltenham Gloucestershire GL50 3LG England a The Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW in data 01 ago 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 06 lug 2017

    LRESEX

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 mag 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 mag 2017

    RES15

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    25 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Outsauce Accounting Limited il 23 set 2016

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mag 2016

    Stato del capitale al 25 mag 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cheltenham House, Fourth Floor Clarence Street Cheltenham Gloucestershire GL50 3JR a St Georges House 13-14 Ambrose Street Cheltenham Gloucestershire GL50 3LG in data 17 mag 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Miles Spencer Lloyd come amministratore in data 31 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hugh Matthew Fell come amministratore in data 31 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2015

    Stato del capitale al 28 mag 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2014

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2014

    Stato del capitale al 08 lug 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Mr Steven Michael Hartley come amministratore

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 051359190008

    39 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 051359190009

    39 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di ORCHID8 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OUTSAUCE ACCOUNTING LIMITED
    13-14 Ambrose Street
    GL50 3LG Cheltenham
    St Georges House
    England
    Segretario
    13-14 Ambrose Street
    GL50 3LG Cheltenham
    St Georges House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione08260019
    173123190001
    HARTLEY, Steven Michael
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritish80734990001
    WORTLEY, Steven Paul
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritish138137130001
    COPLEY, Philip
    30 Eagle Way
    Abbeydale
    GL4 4WS Gloucester
    Gloucestershire
    Segretario
    30 Eagle Way
    Abbeydale
    GL4 4WS Gloucester
    Gloucestershire
    British111621810001
    JONES, Adam James
    23 Marle Hill Road
    GL50 4LN Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    23 Marle Hill Road
    GL50 4LN Cheltenham
    Gloucestershire
    British115536160001
    LEIGHTON, Benjamin
    69 Denmark Road
    Kingsholm
    GL1 3JL Gloucester
    Glos
    Segretario
    69 Denmark Road
    Kingsholm
    GL1 3JL Gloucester
    Glos
    British115467620001
    MITCHELL, Patricia Marjorie Delaval
    Queensholme Pittville Circus Road
    GL52 2QE Cheltenham
    8
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Queensholme Pittville Circus Road
    GL52 2QE Cheltenham
    8
    Gloucestershire
    United Kingdom
    British129121670001
    MITCHELL, Patricia Marjorie Delaval
    128 Bath Road
    GL53 7JX Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    128 Bath Road
    GL53 7JX Cheltenham
    Gloucestershire
    British70278180001
    PURSEY, Brian Patrick
    Pickering House
    Orchard Road Winchcombe
    GL54 5QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Pickering House
    Orchard Road Winchcombe
    GL54 5QB Cheltenham
    Gloucestershire
    British102079990001
    VIZARD, David
    46 Rosedale Close
    Hardwicke
    GL2 4JL Gloucester
    Glos
    Segretario
    46 Rosedale Close
    Hardwicke
    GL2 4JL Gloucester
    Glos
    British115479430001
    ORIEL ACCOUNTING LIMITED
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Cheltenham House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Cheltenham House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05501145
    131679010001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    COPLEY, Su
    30 Eagle Way
    Abbeydale
    GL4 4WS Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    30 Eagle Way
    Abbeydale
    GL4 4WS Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish147773430001
    FELL, Hugh Matthew
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish83313220002
    LLOYD, Miles Spencer
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish120836150001
    PURSEY, Brian Patrick
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cheltenham House, Fourth Floor
    Clarence Street
    GL50 3JR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish102079990001
    PURSEY, Brian Patrick
    Pickering House
    Orchard Road Winchcombe
    GL54 5QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pickering House
    Orchard Road Winchcombe
    GL54 5QB Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish102079990001
    STALLEY, Adrian James
    Dryland Mews
    Hucclecote
    GL3 3UP Gloucester
    11
    Gloucestershire
    Amministratore
    Dryland Mews
    Hucclecote
    GL3 3UP Gloucester
    11
    Gloucestershire
    EnglandBritish99089660001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    ORCHID8 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 gen 2014
    Consegnato il 11 feb 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Energize Capital Limited
    Transazioni
    • 11 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 gen 2014
    Consegnato il 11 feb 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Energize Capital Limited
    Transazioni
    • 11 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2012
    Consegnato il 06 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Oriel Receivables Limited
    Transazioni
    • 06 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 23 ott 2012
    Consegnato il 26 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 26 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge f/h or l/h property, all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, goodwill and uncalled capital, all debts and by way of first floating charge all the undertaking, property, assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Energize Capital Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    All assets debenture
    Creato il 17 gen 2012
    Consegnato il 19 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2011
    Consegnato il 24 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 gen 2007
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 20 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ORCHID8 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 lug 2017Inizio della liquidazione
    12 apr 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0