MAGIC NURSERIES `A` LIMITED

MAGIC NURSERIES `A` LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAGIC NURSERIES `A` LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05137661
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    • Istruzione prescolare (85100) / Istruzione

    Dove si trova MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tuscany House
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Hampshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 051376610020 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Lydia Joy Hopper il 08 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Prism Cosec Limited il 26 mag 2021

    1 pagineCH04

    Stato del capitale al 20 apr 2021

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Adrian Richard Moore come amministratore in data 17 lug 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Lydia Joy Hopper come amministratore in data 17 lug 2020

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Richard Moore il 17 giu 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin James Lawson il 15 mag 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin James Lawson il 15 mag 2020

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRISM COSEC LIMITED
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05533248
    116519070002
    HOPPER, Lydia Joy
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish273239570002
    LAWSON, Colin James
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish238908190001
    REED, Jean Patricia, Dr
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    British84319810001
    REED, Thomas Christian
    13 Esmond Road
    W4 1JG London
    Segretario
    13 Esmond Road
    W4 1JG London
    British82247050002
    WRIGHT, Zoe Louise
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    205435200001
    ALI, Syed Haider
    c/o Magic Nurseries 'A' Ltd
    Fishers Lane
    W4 1RX London
    Swan Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Magic Nurseries 'A' Ltd
    Fishers Lane
    W4 1RX London
    Swan Centre
    United Kingdom
    SingaporePakistani97946730002
    GRIFFITH, Ellis Keith
    105 Queenswood Gardens
    Wanstead
    E11 3SF London
    Amministratore
    105 Queenswood Gardens
    Wanstead
    E11 3SF London
    EnglandBritish90661250001
    MOORE, Adrian Richard
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish96121170002
    REED, Thomas Christian
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    Amministratore
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    JerseyBritish132988450003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Grandir Uk Limited
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    03 gen 2017
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione10519700
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MAGIC NURSERIES `A` LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2017
    Consegnato il 02 gen 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent
    Transazioni
    • 02 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 apr 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 gen 2015
    Consegnato il 02 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Property k/a 471 wellingborough road northampton titel no NN50700.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 ago 2014
    Consegnato il 15 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property known as the laurels 1514 melton road queniborough leicester t/n LT83619.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2014
    Consegnato il 01 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H grove mill, 117 grove road, hitchin, hertfordshire, being the whole of the property registered with f/h title number HD391748.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H ravenstone house, the common, redbourn, st albans, being the whole of the property registered with f/h title number HD264527.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 473 wellingborough road, northampton, northamptonshire, being the whole of the property registered with f/h title number NN81860.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 45 barwell road, kirby muxloe, being the whole of the property registered with f/h title number LT304446.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 120 charnwood road, shepshed, leicester, being the whole of the property registered with f/h title number LT78015.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2012
    Consegnato il 06 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the west side of market place and north west side of silver street being the whole of the property registered with f/h title number LT265408.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 set 2012
    Consegnato il 28 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 set 2008
    Consegnato il 25 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 21 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Grove mill 117 grove road hitchin herts. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2007
    Consegnato il 03 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ravenstone house northcote south common hemel hempstead road redbourn herts. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2007
    Consegnato il 03 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ravenstone house 473 wellingborough road northampton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 45 barwell road, kirby, muxloe, t/no LT304446. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings on the west side of market place and north west side of silver street, t/no LT265408. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 120 charnwood road, shepshed, LT78015. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of pinfoldgate, loughborough, t/no LT242762. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0