BRAND NEW CO (225) LIMITED

BRAND NEW CO (225) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRAND NEW CO (225) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05137991
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARDSLEY LIMITED12 ago 200512 ago 2005
    BRAND NEW CO (225) LIMITED26 mag 200426 mag 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2020

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2019

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2018

    17 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG a 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB in data 11 mag 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 26 apr 2017

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name09 set 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 20 lug 2016

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 giu 2016

    Stato del capitale al 20 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    15 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2015

    Stato del capitale al 16 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Graeme Spencer come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2014

    Stato del capitale al 13 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Graeme Spencer il 26 mag 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Roland Bardsley il 26 mag 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neil Macdougal come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARDSLEY, Roland
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Amministratore
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    United KingdomBritish140518810002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Amministratore
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    EnglandBritish46232460002
    RAFTERY, Paul Matthew
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    Segretario
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    British62586740002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Segretario
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    British163442060001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    PURKIS, Stephen Robert
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Amministratore
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish135467600002
    SPENCER, Graeme
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Amministratore
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish140712180002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Amministratore
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    United KingdomBritish163442060001
    THOMPSON, Alan Christopher
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    United KingdomBritish39558890001

    BRAND NEW CO (225) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 mag 2011
    Consegnato il 11 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Blocked account charge
    Creato il 08 apr 2010
    Consegnato il 15 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2006
    Consegnato il 19 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 nov 2004
    Consegnato il 15 nov 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    BRAND NEW CO (225) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2021Data prevista di scioglimento
    26 apr 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Vincent Andrew Simmons
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Praticante
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0