BRAND NEW CO (225) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRAND NEW CO (225) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05137991 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRAND NEW CO (225) LIMITED?
- Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni
Dove si trova BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 7 St. Petersgate SK1 1EB Stockport Cheshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BARDSLEY LIMITED | 12 ago 2005 | 12 ago 2005 |
| BRAND NEW CO (225) LIMITED | 26 mag 2004 | 26 mag 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 16 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2020 | 14 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2019 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2018 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG a 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB in data 11 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19 | 5 pagine | 4.20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Graeme Spencer come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Graeme Spencer il 26 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Roland Bardsley il 26 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Macdougal come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDSLEY, Roland | Amministratore | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | United Kingdom | British | 140518810002 | |||||
| BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul | Amministratore | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | England | British | 46232460002 | |||||
| RAFTERY, Paul Matthew | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | 62586740002 | ||||||
| STUBLEY, Caroline | Segretario | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | British | 163442060001 | ||||||
| MACDOUGAL, Neil Charles | Amministratore | The Garden House Off Chester Road, Tabley WA16 OHA Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 93401120003 | |||||
| MCCARREN, Lee Scott | Amministratore | Chadwicks Close Farm Off Coal Pit Road Smithills BL1 7PB Bolton Lancashire | England | British | 107908930001 | |||||
| PURKIS, Stephen Robert | Amministratore | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 135467600002 | |||||
| SPENCER, Graeme | Amministratore | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 140712180002 | |||||
| STUBLEY, Caroline | Amministratore | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | United Kingdom | British | 163442060001 | |||||
| THOMPSON, Alan Christopher | Amministratore | 21a Spath Road Didsbury M20 2QT Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 39558890001 |
BRAND NEW CO (225) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 05 mag 2011 Consegnato il 11 mag 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Blocked account charge | Creato il 08 apr 2010 Consegnato il 15 apr 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 nov 2007 Consegnato il 28 nov 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 lug 2006 Consegnato il 19 lug 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 ott 2005 Consegnato il 27 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 nov 2004 Consegnato il 15 nov 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BRAND NEW CO (225) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0