WHITE STAR LEISURE PLC

WHITE STAR LEISURE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITE STAR LEISURE PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05147351
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITE STAR LEISURE PLC?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova WHITE STAR LEISURE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Libertas 3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITE STAR LEISURE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WHITE STAR ENERGY PLC10 mar 200910 mar 2009
    WHITE STAR PROPERTY HOLDINGS PLC16 feb 200616 feb 2006
    EURO CAPITAL PROJECTS PLC22 giu 200422 giu 2004
    ORIENTROSE 4 PLC07 giu 200407 giu 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE STAR LEISURE PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITE STAR LEISURE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2023

    24 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 07 dic 2021

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    18 pagineLIQ02

    Indirizzo della sede legale modificato da Milner House 14 Manchester Square London W1U 3PP England a C/O Libertas 3 Chandler House, Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne Bushey Hertfordshire WD23 1FL in data 15 dic 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 set 2021 con aggiornamenti

    16 pagineCS01

    Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 10 set 2020

    20 pagineRP04CS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    19 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Lucy Kathleen Jewell il 25 nov 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Limestar Investments Limited il 19 nov 2020

    1 pagineCH04

    Modifica dei dettagli di Mr Geoffrey Hugh Melamet come persona con controllo significativo il 16 nov 2020

    2 paginePSC04

    10/09/20 Statement of Capital gbp 3046694.996

    21 pagineCS01
    Note
    DataNota
    24 feb 2021Clarification A second filed CS01(amending Statement of capital and shareholder information) was registered on 24/02/2021.

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ago 2019 con aggiornamenti

    23 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2018 con aggiornamenti

    26 pagineCS01

    Cessazione di Keith Leslie Atkinson come persona con controllo significativo il 01 gen 2018

    3 paginePSC07

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    21 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor 3 Crawford Place London W1H 4LB England a Milner House 14 Manchester Square London W1U 3PP in data 20 lug 2018

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2017 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 lug 2016 con aggiornamenti

    61 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Hmsa Ltd 100 Seymour Place London W1H 1NE England a 1st Floor 3 Crawford Place London W1H 4LB in data 24 nov 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di WHITE STAR LEISURE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LIMESTAR INVESTMENTS LIMITED
    14 Manchester Square
    W1U 3PP London
    Milner House
    England
    Segretario
    14 Manchester Square
    W1U 3PP London
    Milner House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2268111
    94206670002
    JEWELL, Lucy Kathleen
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    EnglandBritish182337000002
    MELAMET, Geoffrey Hugh
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2209360001
    ATKINSON, Keith Leslie
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Segretario
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    188932750001
    FARMILOE, Andrew Derrick John
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Segretario
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    190663650001
    MAY, Graham Philip
    Floor 36
    Spital Square
    E1 6DY London
    4th
    England
    Segretario
    Floor 36
    Spital Square
    E1 6DY London
    4th
    England
    177961300001
    NICHOLLS, Vincent William
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    British124916980001
    ROUZEL, Alan Keith
    88 Montrose Avenue
    HA8 0DR Edgware
    Middlesex
    Segretario
    88 Montrose Avenue
    HA8 0DR Edgware
    Middlesex
    British55714880001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    CONGRESS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St John's Road
    HA1 2EY Harrow
    7
    Middlesex
    Segretario
    St John's Road
    HA1 2EY Harrow
    7
    Middlesex
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03525413
    293584180001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ALLEN, Robert Keith
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Amministratore
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    EnglandEnglish44871030002
    ATKINSON, Keith Leslie
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Amministratore
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish80263550003
    BASHAM, Brian Arthur
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    Amministratore
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    United KingdomBritish69378240003
    DEAN, Stephen
    610 Euro Tower
    Europort Road
    Gibraltar
    Amministratore
    610 Euro Tower
    Europort Road
    Gibraltar
    British103038770001
    DEAN, Stephen
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    British76827800002
    GARVIN, Michael Samuel Philip
    Flat 7
    103-105 Harley Street
    W1G 6AJ London
    Amministratore
    Flat 7
    103-105 Harley Street
    W1G 6AJ London
    United KingdomBritish49337220002
    GIL, Alberto Manuel
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Amministratore
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish99545050002
    HALL, Mark Andrew
    Sambourne Road
    BA12 8LL Warminster
    39
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Sambourne Road
    BA12 8LL Warminster
    39
    Wiltshire
    England
    United KingdomBritish166498830001
    HAND, John Lester
    7 Ordnance Hill
    NW8 6PR London
    Amministratore
    7 Ordnance Hill
    NW8 6PR London
    EnglandBritish98898900001
    HEMINGWAY, John
    The Oast House
    Delaware Farm, Hever Road
    TN8 7LD Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    The Oast House
    Delaware Farm, Hever Road
    TN8 7LD Edenbridge
    Kent
    British76213390009
    LLOYD COOPER, Peter Ross
    5 Westmoreland Place
    SW1V 4AB London
    Amministratore
    5 Westmoreland Place
    SW1V 4AB London
    UkBritish56679430001
    NASH, Michael Raymond
    8 Parkinson Close
    AL4 8DP Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Parkinson Close
    AL4 8DP Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish28045530003
    NICHOLLS, Vincent William
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish124916980001
    RISBEY, David John
    Baarerstrasse 75
    Zug
    6302
    Switzerland
    Amministratore
    Baarerstrasse 75
    Zug
    6302
    Switzerland
    Swiss113720350001
    TENUTA, Luca
    Flat 6
    39 Sutherland Avenue
    W9 2HE London
    Amministratore
    Flat 6
    39 Sutherland Avenue
    W9 2HE London
    United KingdomItalian119743150002
    TURPIN, Carl Stephen
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Amministratore
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    United KingdomBritish85268420001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Amministratore
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    CROFT NOMINEES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Amministratore
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    71126780002

    Chi sono le persone con controllo significativo di WHITE STAR LEISURE PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Keith Leslie Atkinson
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Hoft The Hollies
    West Sussex
    United Kingdom
    05 lug 2016
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Hoft The Hollies
    West Sussex
    United Kingdom
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Geoffrey Hugh Melamet
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    05 lug 2016
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    WHITE STAR LEISURE PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 giu 2010
    Consegnato il 22 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Zengreen Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2007
    Consegnato il 19 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £631,788.01 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 park road hackbridge t/no SGL388585.
    Persone aventi diritto
    • Stephen Oliver Brook and Michael Maurice Martin
    Transazioni
    • 19 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All securities, all dividends interest and other distributions and all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 nov 2006
    Consegnato il 30 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2006
    Consegnato il 11 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All book and other debts the benefit of all rights relating to the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dcf (UK) Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WHITE STAR LEISURE PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mag 2024Data prevista di scioglimento
    07 dic 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Barnett
    3 Chandlers House Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire
    Praticante
    3 Chandlers House Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0