CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED

CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05150138
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?

    • (8514) /

    Dove si trova CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di David Manson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David James Hall come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Philip Henry Scott come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jason David Lock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Franzidis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Morrison come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christine Cameron come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Albert Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Ball come amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 giu 2010

    Stato del capitale al 30 giu 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Julian Spurling come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    13 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine353a

    legacy

    1 pagine190a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159633840001
    EVANS, Avril Emma Margaret
    Woodlands
    Quarhouse Brimscombe
    GL5 2RR Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Woodlands
    Quarhouse Brimscombe
    GL5 2RR Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector111954610001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUkDirector129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector174231320001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Segretario
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Carole
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director102238960001
    BAILEY, Anne
    25 Church Lane
    SK7 1RQ Woodford
    Cheshire
    Amministratore
    25 Church Lane
    SK7 1RQ Woodford
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director118289800001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Amministratore
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector138044110001
    BYRNE, Michael
    71a-71c High Street
    TN21 8HU Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    71a-71c High Street
    TN21 8HU Heathfield
    East Sussex
    CanadianCompany Director100296200001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Finance Officer113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Amministratore
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritishCompany Director163745150001
    CAVANAGH, Peter Kenneth
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    Amministratore
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    BritishCompany Director114627410002
    FOTHERGILL, David
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    BritishDirector35902810001
    HAYES, Paul Stuart
    The Long Barn Shoulton
    Hallow
    WR2 6PX Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Long Barn Shoulton
    Hallow
    WR2 6PX Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector92558190002
    HILL, Margaret
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director102587360001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director111513540001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant126071210001
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director110957990001
    NEWELL, John
    2 Spratts Bridge
    Chew Magna
    BS40 8RZ Bristol
    Amministratore
    2 Spratts Bridge
    Chew Magna
    BS40 8RZ Bristol
    BritishDirector87428820001
    POINTER, David Richard
    Cuckoo Cottage
    Cuckoo Cage Lane Tatenhill
    DE13 9RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Cuckoo Cottage
    Cuckoo Cage Lane Tatenhill
    DE13 9RX Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director283804350001
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Amministratore
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritishCompany Director124068010001
    SAVILLE, Richard Cyril Campbell
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector38530070001
    SMIT, Wynne Carol
    506 Oundle Road
    Orton Longueville
    PE2 7DJ Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    506 Oundle Road
    Orton Longueville
    PE2 7DJ Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director114625570001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishChief Executive Officer77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Amministratore
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director110225070001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 08 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 08 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 11 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the book and record,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the book and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash.the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Overdraft debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 02 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent and Trustee for Itself and the Lenders)
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Development debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 18 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Acquisito il 31 dic 2004
    Consegnato il 17 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000,000
    Brevi particolari
    The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0