SPEEDFIT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPEEDFIT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05156671
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPEEDFIT LIMITED?

    • Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
    • Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni

    Dove si trova SPEEDFIT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPEEDFIT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per SPEEDFIT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 051566710010 in pieno

    1 pagineMR04

    Stato del capitale al 28 set 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account be cancelled 17/09/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Sure Maintenance Group Limited come persona con controllo significativo il 13 apr 2020

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Patrick Joseph Coleman come amministratore in data 10 mar 2020

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Peter David Mawby Smith come amministratore in data 01 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Mcmahon come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Stephen Cornes come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR United Kingdom a Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane Basildon Essex SS14 3BZ in data 09 apr 2019

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 051566710009 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 051566710010, creata il 19 dic 2018

    69 pagineMR01

    Nomina di Mr John William Charles Charlton come amministratore in data 12 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeremy John Cobbett Simpson come amministratore in data 15 ott 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 King George Close Romford Essex RM7 7LS United Kingdom a St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR in data 11 mag 2018

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SPEEDFIT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHARLTON, John William Charles
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Segretario
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    230717980001
    CHARLTON, John William Charles
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Secretary119598150002
    COLEMAN, Patrick Joseph
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director259978320001
    SMITH, Peter David Mawby
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer159286600001
    DWYER, Daniel John
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    Segretario
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    British112335920001
    HAYES, Chris
    Windsor Road
    PR9 9DB Southport
    49
    Merseyside
    Uk
    Segretario
    Windsor Road
    PR9 9DB Southport
    49
    Merseyside
    Uk
    BritishAccountant135198810001
    HOWELL, Simon John
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    202440460001
    JONES, Mark Andrew
    13 Rutters Lane
    Hazel Grove
    SK7 5AY Stockport
    Cheshire
    Segretario
    13 Rutters Lane
    Hazel Grove
    SK7 5AY Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant122429790001
    KERRY, Simon
    St Kenelm Court
    Steelpark Road
    B62 8HD Halesowen
    4
    West Midlands
    England
    Segretario
    St Kenelm Court
    Steelpark Road
    B62 8HD Halesowen
    4
    West Midlands
    England
    150202190001
    LLEWELLYN, Mark Stephen
    21 High Street
    Tutbury
    DE13 9LS Burton-On-Trent
    Robinia House
    Staffordshire
    Segretario
    21 High Street
    Tutbury
    DE13 9LS Burton-On-Trent
    Robinia House
    Staffordshire
    EnglishAccountant201025330001
    MCCURDY, Barry James Joseph
    21 Claremont Drive
    WA8 9LX Widnes
    Cheshire
    Segretario
    21 Claremont Drive
    WA8 9LX Widnes
    Cheshire
    British80677910002
    SILK, Frances
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Segretario
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    British94515450002
    BIRRANE, Sean Thomas
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector101296120004
    BLACK, Stuart John
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector49053310001
    CORNES, Paul Stephen
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector155586570001
    CUNNINGHAM, Darren
    Fairways
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Fairways
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AP Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishMarketing66265530004
    DWYER, Daniel James
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    Amministratore
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Registration Agent86094440001
    JONES, Mark Andrew
    13 Rutters Lane
    Hazel Grove
    SK7 5AY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    13 Rutters Lane
    Hazel Grove
    SK7 5AY Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant122429790001
    KERRY, Simon
    St. Kenelm Court
    Steelpark Road
    B62 8HD Halesowen
    4
    West Midlands
    England
    Amministratore
    St. Kenelm Court
    Steelpark Road
    B62 8HD Halesowen
    4
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector147820500001
    LLEWELLYN, Mark Stephen
    21 High Street
    Tutbury
    DE13 9LS Burton-On-Trent
    Robinia House
    Staffordshire
    Amministratore
    21 High Street
    Tutbury
    DE13 9LS Burton-On-Trent
    Robinia House
    Staffordshire
    EnglandEnglishAccountant201025330001
    MCMAHON, Michael
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    United KingdomBritishCompany Director173928090001
    SHAH, Bharat Chimanlal
    45 Dene Road
    HA6 2DD Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    45 Dene Road
    HA6 2DD Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector92761250002
    SILK, Frances
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Amministratore
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance Director94515450002
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director187009310001
    VIITIKKO, Heikki Kalevi
    4 Aynsley Court
    WA9 5GE St. Helens
    Amministratore
    4 Aynsley Court
    WA9 5GE St. Helens
    FinnishManaging Director72705340002
    WINKS, Nicholas Paul David
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151282040001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SPEEDFIT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    30 giu 2016
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5319177
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SPEEDFIT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2018
    Consegnato il 24 dic 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 mag 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 dic 2015
    Consegnato il 14 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2012
    Consegnato il 14 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP (Security Trustee)
    Transazioni
    • 14 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental debenture
    Creato il 18 mar 2010
    Consegnato il 25 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new loan notes are deemed to form part of the A1 loan notes for the purposes of the debenture see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2009
    Consegnato il 03 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders (or any of them) or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP as Security Trustee for the Noteholders
    Transazioni
    • 03 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 21 mag 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money, including bonuses, that has accrued or may become payable under the pheikki viitikko, date of policy: 15/10/04, insurer: st. James's place, policy number: 43C03P00, sum assured: £550,000 term date: 4 years; heikki viitikko, date of policy: 15/10/04, insurer: st. James's place, policy number: 43C36J57, sum assured: £1.8M term date: 2 years;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling;.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0