CELOTEX GROUP LIMITED

CELOTEX GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCELOTEX GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05162972
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CELOTEX GROUP LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CELOTEX GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CELOTEX GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 2151 LIMITED25 giu 200425 giu 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di CELOTEX GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CELOTEX GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CELOTEX GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Saint Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT a Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD in data 16 ott 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2014

    LRESSP

    Cessazione della carica di Nicolas Suret come amministratore in data 21 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Strickland Chaldecott come amministratore in data 21 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Edward Moore come amministratore in data 21 lug 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Alun Roy Oxenham come amministratore in data 21 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Emmanuel Du Moulin come amministratore in data 21 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Stephen Chambers come amministratore in data 21 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Adam Gilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 25 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2014

    Stato del capitale al 25 giu 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Varie

    Aud sect 519
    3 pagineMISC

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di Mr Craig Stephen Chambers come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Adam Quincey Gilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Goddard come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Strickland Chaldecott come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Anderson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Pemberton come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di David Anderson come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CELOTEX GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OXENHAM, Alun
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Segretario
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    British172155000001
    MOORE, Philip Edward
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United KingdomBritish60599570002
    OXENHAM, Alun Roy
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish72478560002
    GODDARD, Mark Sean
    7 Woods Walk
    IP5 2DG Kesgrave
    Suffolk
    Segretario
    7 Woods Walk
    IP5 2DG Kesgrave
    Suffolk
    British72322400003
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    ANDERSON, David
    East Leake
    LE12 6JS Loughborough
    Bpb Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6JS Loughborough
    Bpb Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish128900720001
    CHALDECOTT, Michael Strickland
    East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Head Office
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Head Office
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish126434970001
    CHAMBERS, Craig Stephen
    Hadleigh
    IP7 6BA Ipswich
    Lady Lane Industrial Estate
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Hadleigh
    IP7 6BA Ipswich
    Lady Lane Industrial Estate
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish177521000001
    DU MOULIN, Emmanuel
    Saint Gobain House
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Amministratore
    Saint Gobain House
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    United KingdomFrench163728500001
    GILSON, Adam Quincey
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    EnglandBritish177261700001
    GODDARD, Mark Sean
    7 Woods Walk
    IP5 2DG Kesgrave
    Suffolk
    Amministratore
    7 Woods Walk
    IP5 2DG Kesgrave
    Suffolk
    United KingdomBritish72322400003
    HARPER, Digby John
    Roke Barn 18 Fifield Barns
    Benson
    OX10 6EZ Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Roke Barn 18 Fifield Barns
    Benson
    OX10 6EZ Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish26395190002
    LONG, David Brian
    Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    2a
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    2a
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish40011570003
    MACLELLAN, Ian David
    Wormleighton Grange
    CV47 2XZ Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Wormleighton Grange
    CV47 2XZ Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritish33693580001
    MOXON, Paul Keith
    60 Abington Grove
    NN1 4QU Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    60 Abington Grove
    NN1 4QU Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish151403860004
    NEALE, Christopher James
    Castle Mews
    KT13 9QY Weybridge
    9
    Surrey
    Amministratore
    Castle Mews
    KT13 9QY Weybridge
    9
    Surrey
    UkBritish133653500004
    PEMBERTON, Richard Stratten
    11b Noverton Lane
    Prestbury
    GL52 5BA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    11b Noverton Lane
    Prestbury
    GL52 5BA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish116545210001
    SURET, Nicolas
    Les Miroirs
    18 Avenue D'Alsace 92400
    Courbevoie
    Saint-Gobain Isover
    France
    Amministratore
    Les Miroirs
    18 Avenue D'Alsace 92400
    Courbevoie
    Saint-Gobain Isover
    France
    FranceFrench172011450001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    CELOTEX GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 ago 2011
    Consegnato il 09 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2011
    Consegnato il 09 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 09 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 21 apr 2005
    Consegnato il 26 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Agrees to assign with full title guarantee the policies and all monies which shall become payable under it and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC as Security Trusteefor the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Agrees to assign with full title guarantee the policies and all monies which shall become payable under it and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC as Security Trusteefor the Secured Parties
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 27 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any stockholder or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Capital Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 22 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at lady lane industrial estate hadleigh ipswich t/no SK214196, f/h land lying to the north west of lady of lady lane hadleigh ipswich t/no SK203174, f/h land lying to the west of lady lane hadleigh ipswich t/no SK174224. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC as Security Trusteefor the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CELOTEX GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 2014Inizio della liquidazione
    10 set 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nigel Heath Sinclair
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0