STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED
Panoramica
Nome della società | STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05166163 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AMAZON CATERING LIMITED | 30 giu 2004 | 30 giu 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 14 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 apr 2018 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Guthrie come segretario in data 03 mag 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 33 Holborn London EC1N 2HT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 33 Holborn London EC1N 2HT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 33 Holborn London EC1N 2HT a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 03 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 4 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 13 mar 2016 al 13 set 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ago 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony Guthrie come segretario in data 12 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hazel Debra Jarvis come segretario in data 12 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 4 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 14 mar 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Christopher Paul Templeman come amministratore in data 17 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jamie John Baker come amministratore in data 17 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 15 mar 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 20 mar 2015 al 13 mar 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Hazel Debra Jarvis come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPLEMAN, Christopher Paul, Dr | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | Chartered Surveyor | 121772780002 | ||||||||
SAINSBURYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 England |
| 122349710001 | ||||||||||
DAVIES, Philip | Segretario | Holborn EC1N 2AT London 33 | British | 153838560001 | ||||||||||
GRAEME, Dorothy May | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
GUTHRIE, Anthony | Segretario | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | 207197840001 | |||||||||||
JARVIS, Hazel Debra | Segretario | Holborn EC1N 2HT London 33 | British | 185640170001 | ||||||||||
THOMAS, Jonathan Riou Blake | Segretario | 365a Woodstock Road OX2 8AA Oxford | British | Chartered Surveyor | 28823200006 | |||||||||
BAKER, Jamie John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 | England | British | Company Director | 151567380001 | ||||||||
FLEMING, Richard Alexander | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 125990210002 | ||||||||
GRAEME, Lesley Joyce | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
LIGGINS, John William Ewart | Amministratore | Hopcraft Lane Ardens Grafton OX15 0TD Deddington Orchard House Oxfordshire England | United Kingdom | British | Surveyor | 75243570007 | ||||||||
RUHAN, Andrew Joseph | Amministratore | High Trees Shire Lane Horn Hill SL9 0QY Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 154690700001 | ||||||||
THOMAS, Jonathan Riou Blake | Amministratore | 365a Woodstock Road OX2 8AA Oxford | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 28823200006 | ||||||||
THOMPSON, Andrew | Amministratore | 100 Bridge End CV34 6PD Warwick Warwickshire | British | Property Development | 66204940002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Sainsbury Plc | 06 apr 2016 | Holborn EC1N 2HT London 33 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 29 mar 2010 Consegnato il 03 apr 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H properties k/a pevensey house 27 sheep street bicester oxfordshire t/n ON264974 and greytown house 43-47 sheep street bicester oxfordshire t/n ON254731 and all buildings fixtures plants and machinery goodwill and rents see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 gen 2007 Consegnato il 17 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or any security provider to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All f/h property k/a pevensey house 27 sheep street bicester oxfordshire t/no ON264974. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent assignment | Creato il 10 gen 2007 Consegnato il 17 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to any rental income payable under any lease to which the mortgaged property is subject. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge of deposit | Creato il 10 gen 2007 Consegnato il 17 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All rights title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Commercial mortgage deed | Creato il 31 gen 2005 Consegnato il 05 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property known as greytown house 43-47 sheep street bicester oxfordshire,and all buildings fixtures plant and machinery, goodwill, rents,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 31 gen 2005 Consegnato il 05 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the undertaking property and assets of the company present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
STOCKDALE LAND (BICESTER) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0