COILBAY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COILBAY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05176330 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COILBAY LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova COILBAY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA Greater Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COILBAY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per COILBAY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 19 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2022 | 19 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Old Heath Road Wolverhampton Wolverhampton West Midlands WV1 2QT a Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA in data 05 ago 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 9 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2020 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2019 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 con aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Theodore Berenzweig il 13 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Dryden il 13 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Georg Heinrich Johannes Strierath il 13 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||
Aggiornamento delle informazioni del registro dei soci nel registro pubblico | 6 pagine | EH06 | ||||||||||
Notifica di The Goldman Sachs Group Inc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 4 pagine | PSC02 | ||||||||||
Scegliere di mantenere le informazioni del registro delle persone con controllo significativo nel registro pubblico | 2 pagine | EH04 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jayne Evelyn Williams come segretario in data 12 apr 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COILBAY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Jayne Evelyn | Segretario | Bury New Road Whitefield M45 7TA Greater Manchester Leonard Curtis House, Elms Square | 231972170001 | |||||||
| BERENZWEIG, Jeremy Theodore | Amministratore | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | England | British | 130485700002 | |||||
| DRYDEN, Stephen | Amministratore | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | England | British | 231621730002 | |||||
| STRIERATH, Georg Heinrich Johannes | Amministratore | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | Germany | German | 194506770011 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Segretario | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | British | 16795230001 | ||||||
| FOXLEY, Russell Barry James | Segretario | Stane Street Slinfold RH13 0SH Horsham West Sussex | British | 126099560001 | ||||||
| GODFREY, Stephen Richard | Segretario | Hardtstr D-71711 Steinheim An Der Murr 12 Germany | 157868750001 | |||||||
| SHARMAN, Alistair Richard Norris | Segretario | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | 184435510001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BISSELL, Michael John | Amministratore | 16 Leadhall Grove HG2 9ND Harrogate North Yorkshire | England | British | 72109080004 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Amministratore | Northbank Industrial Park M44 5BL Irlam Varn House Greater Manchester United Kingdom | Uk | British | 16795230001 | |||||
| GODFREY, Stephen Richard | Amministratore | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | Germany | British | 157863660001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Amministratore | Nutwood House Wormley West End EN10 7QN Broxbourne Hertfordshire | British | 98832270001 | ||||||
| NIEBERDING, Sean Alexander | Amministratore | Wieland Strasse 10 Frankfurt Am Main FOREIGN Germany D-60318 | American | 100631580001 | ||||||
| POULSON, Howard | Amministratore | Field Gap Trip Garth LS22 4HY Linton Wetherby West Yorkshire | British | 37394840002 | ||||||
| PUDGE, David John | Amministratore delegato nominato | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 | ||||||
| SHARMAN, Alistair Richard Norris | Amministratore | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | United Kingdom | British | 253658340001 | |||||
| WILDMOSER, Christian | Amministratore | Route De Jorat 16 Savigny FOREIGN Switzerland 1073 | Austrian | 100630490001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COILBAY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group Inc | 06 apr 2016 | West Street Ny 10282 New York 200 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc | 06 apr 2016 | West Street Ny 10282, New York 200 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COILBAY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 17 mar 2011 Consegnato il 30 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 mag 2007 Consegnato il 13 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 dic 2006 Consegnato il 22 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all charged deposits, all investments and shares and all related rights, all rights title interests and benefits in to or in respect of the insurances and all claims, any interest claim or entitlement in to or in respect of any pension fund, goodwill uncalled capital and intellectual proeprty rights. By way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A bank account assignment | Creato il 30 set 2005 Consegnato il 13 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the senior finance parties, the tranche d lenders and the mezzanine finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The existing bank account assignments the deposit to the security agent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 2005 Consegnato il 13 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the real property plant machinery and equipment charged deposits the insurances and all claims the goodwill of the company floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bank account assignment | Creato il 23 dic 2004 Consegnato il 06 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari With full title guarantee the deposit being the balance standing to the credit of the accounts numbered 32172101 and 32172102,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 dic 2004 Consegnato il 10 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
COILBAY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0