CLPE ROC - 2A LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CLPE ROC - 2A LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05188043 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CLPE ROC - 2A LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EVER 2409 LIMITED | 23 lug 2004 | 23 lug 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Octopus Company Secretarial Services Limited come segretario in data 15 nov 2018 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Sharna Ludlow come segretario in data 15 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 5 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stephen Latham il 07 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Company Secretary Sharna Ludlow il 15 mar 2018 | 1 pagine | CH03 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 19 feb 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 30 ott 2017 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Paul Stephen Latham come amministratore in data 15 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew George Setchell il 20 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Tim James Senior come amministratore in data 06 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Matthew George Setchell come amministratore in data 06 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT | 2 pagine | AD04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Company Secretary Sharna Ludlow il 31 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||
Nomina di Company Secretary Sharna Ludlow come segretario in data 06 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Karen Ward come segretario in data 06 mag 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 14 & 15 Queensbrook Bolton Technology Exchange Spa Road Bolton BL1 4AY a 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT in data 01 apr 2016 | 1 pagine | AD01 | ||
Chi sono gli amministratori di CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Holborn EC1N 2HT London 33 England England |
| 253893850001 | ||||||||||
| LATHAM, Paul Stephen | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | United Kingdom | British | 146527710002 | |||||||||
| SETCHELL, Matthew George | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 157021230004 | |||||||||
| WILKINSON, Edwin John | Amministratore | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | England | British | 86926370001 | |||||||||
| BANERJEE, Kamalika Ria | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 239579200001 | |||||||||||
| LUDLOW, Sharna, Company Secretary | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 208103200001 | |||||||||||
| PENTECOST, Alexandra Helen | Segretario | 2 Stratton Villas Milbourne SN16 9JB Malmesbury Wiltshire | British | 70254590001 | ||||||||||
| WARD, Karen | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 204132040001 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||||||
| HOLMES, Randall Duane | Amministratore | 36 Neustadt Lane 10514 Chappaqua New York Ny 10514 Usa | American | 64549270001 | ||||||||||
| PATON, John Derek | Amministratore | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 76165310001 | |||||||||
| SENIOR, Timothy James, Dr | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 244462470001 | |||||||||
| SWANSON, Robert Ernest | Amministratore | 119 Turtle Point Road Tuxedo Park New York 10987 Usa | American | 95188450001 | ||||||||||
| TILSTONE, David Paul | Amministratore | 12 Manor Road TN4 8UE Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 117871440001 | |||||||||
| WEST, Andrew Thomas | Amministratore | 4 Filkins Hall Filkins GL7 3JJ Lechdale Gloucestershire | United Kingdom | British | 79568920001 | |||||||||
| WILSON, Douglas Ralph | Amministratore | 312 Highland Avenue 07450 Ridgewood New Jersey 07450 Usa | American | 91734800002 | ||||||||||
| WYNDHAM, Harry Hugh Patrick | Amministratore | 56 Stockwell Park Crescent SW9 0DG London | England | British | 37118660001 | |||||||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CLPE ROC - 2A LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clpe Projects 3 Limited | 06 apr 2016 | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CLPE ROC - 2A LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debentures | Creato il 21 gen 2010 Consegnato il 22 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 22 feb 2007 Consegnato il 09 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All land equipment insurances debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 04 mag 2006 Consegnato il 17 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company,by each borrower and each other project company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its interest in the property,together with all buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0