POULTER MARKETING GROUP LIMITED

POULTER MARKETING GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOULTER MARKETING GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05188168
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rose Wharf
    East Street
    LS9 8EE Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 3106 LIMITED23 lug 200423 lug 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ago 2011

    Stato del capitale al 08 ago 2011

    • Capitale: GBP 939,938
    SH01

    legacy

    18 pagineMG01

    Nomina di Mr Trevor John O'reilly come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Knights come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    18 pagineMG01

    Cessazione della carica di Mark Shaw come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Richard Timothy Barfield come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Timothy Barfield come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Shaw come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    8 pagineAA

    legacy

    15 pagineMG01

    Cessazione della carica di William Ronald come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    157835390001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123477010001
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    Amministratore
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    IrelandIrish148130760001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Segretario
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    British129305300001
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Segretario
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    British105115960001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Segretario
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British103609160001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Segretario
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    British107353690001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BUCKLE, Mark Raymond
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish121880340001
    COLTON HAWKINS, Darren John
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    British100773780001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Amministratore
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritish129305300001
    GORING, Nicholas Francis
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100773750001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Amministratore
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    United KingdomBritish105115960001
    MCCALL, Gary William
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish59547330001
    RIVETT JONES, Peter
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish112998390001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish138299060001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish103609160001
    SAXBY, Mark Kenneth Baber
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish59543920002
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107353690001
    TOYNTON, Peter Anthony
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    Amministratore
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    United KingdomBritish9723050002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    PEMBRIDGE PARTNERS LLP
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    85753460001

    POULTER MARKETING GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security confirmation and supplemental deed
    Creato il 13 giu 2011
    Consegnato il 17 giu 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    Creato il 24 feb 2011
    Consegnato il 08 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A confirmatory deed
    Creato il 18 dic 2009
    Consegnato il 04 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A confirmatory deed
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 14 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Creato il 17 mar 2009
    Consegnato il 25 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 20 mar 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security accession deed
    Creato il 15 set 2006
    Consegnato il 27 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustees for the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 ott 2004
    Consegnato il 16 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the loan stock 2006 or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Johnstone Limited (Security Trustee as Trustee for Each of the Holders of the Loan Stock)
    Transazioni
    • 16 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2004
    Consegnato il 12 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0