VION SUBCO TOC LIMITED

VION SUBCO TOC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVION SUBCO TOC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05188566
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VION SUBCO TOC LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione della carne (10110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova VION SUBCO TOC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VION SUBCO TOC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRANFIELD OF CUMBRIA LIMITED02 set 200402 set 2004
    INHOCO 3118 LIMITED23 lug 200423 lug 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di VION SUBCO TOC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VION SUBCO TOC LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VION SUBCO TOC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 mag 2016

    24 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    24 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 apr 2016

    20 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Syndale Court Stadium Way Eurolink Business Park Sittingbourne Kent ME10 3SP a C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU in data 06 mag 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 apr 2015

    LRESSP

    Varie

    Section 519 companies act 2006
    1 pagineMISC

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Jacobus Johannes Maria Straathof come amministratore in data 01 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Maria Jacobus Beckers come amministratore in data 01 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2014

    Stato del capitale al 05 ago 2014

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 8 Orgreave Close Sheffield S13 9NP* in data 12 dic 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 ago 2013

    SH01

    Nomina di Mr Leon Barry Abbitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Steven come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Peter Maria Jacobus Beckers come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Devenney come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Grant Moir come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louis Vernaus come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di VION SUBCO TOC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    STRAATHOF, Jacobus Johannes Maria
    5281 RM Boxtel
    Boseind 15a
    Netherlands
    Amministratore
    5281 RM Boxtel
    Boseind 15a
    Netherlands
    NetherlandsDutch190171680001
    MACDONALD, Alistair
    Three Gables
    Little Top Lane Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Three Gables
    Little Top Lane Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    British89506230001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BECKERS, Peter Maria Jacobus
    Gb
    5657 Eindhoven
    Noord Brabantlaan 303-307
    Netherlands
    Amministratore
    Gb
    5657 Eindhoven
    Noord Brabantlaan 303-307
    Netherlands
    The NetherlandsDutch177524930001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    DEVENNEY, John Anthony
    Liverpool Street
    HU3 4HW Hull
    Tranfield Of Cumbria
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Liverpool Street
    HU3 4HW Hull
    Tranfield Of Cumbria
    Yorkshire
    United Kingdom
    British104512800001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    HUTCHINSON, Mike
    Woodside
    Oldfield Road
    HD9 6NL Holney
    Holmfirth
    Amministratore
    Woodside
    Oldfield Road
    HD9 6NL Holney
    Holmfirth
    British89506310001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    MACDONALD, Alistair
    Three Gables
    Little Top Lane Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Three Gables
    Little Top Lane Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish89506230001
    MOIR, Grant Ronald
    73 Main Street
    KA3 4AG Dunlop
    The Old Mance
    Ayrshire
    Amministratore
    73 Main Street
    KA3 4AG Dunlop
    The Old Mance
    Ayrshire
    ScotlandBritish65445780003
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    WRIGHT, Colin Vincent
    Bentley Hall
    Fenney Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenney Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish43526580002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    VION SUBCO TOC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking security agreement (assignment of receivables)
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 15 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any subordinated secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First ranking security agreement (assignment of receivables)
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 15 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any senior secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2007
    Consegnato il 09 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest due by the company together with all the companys book debts and other debts revenues and claims present future and contingent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC T/a Allied Irish Bank (GB)
    Transazioni
    • 09 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental charge
    Creato il 17 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and intent in and to the specified equipment being 500 pallet space mobile powered racking and 19 bays pallet racking, 42 bays pallet racking, cardinal 2500KG capacity floor scales s/n 9909-229, for details of further equipment charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of green farm shap penarth t/no cu 168958. by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed to a mortgage debenture dated 27 august 2004
    Creato il 04 gen 2005
    Consegnato il 08 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property including f/h land and buildings on the north side of green farm shap penrith t/no CU168958.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to a mortgage debenture
    Creato il 04 gen 2005
    Consegnato il 05 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of green farm shap penrith t/no CU168958. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J & J Tranfield Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ago 2004
    Consegnato il 02 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as inhoco 3118 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north side of green farm shap penrith t/no CU168598 and/or the proceeds of sale thereof. All estates or interests in any f/h and l/h property, all licences and the benefit of all other agreements relating to land, all fixtures, all property rights, all debts, all amounts owing or becoming due on any account. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights, all cash at bank, the stock-in-trade and the property assets and rights charged. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ago 2004
    Consegnato il 02 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a inhoco 3118 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The land and buildings on the north side of green farm shap penrith t/n CU168598 by way of specific equitable charge all estates or interests in any f/h and l/h property all plant and machinery all book debts and other debts goodwill and the benefit of any licences by way of floating security its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J & J Tranfield Limited
    Transazioni
    • 02 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VION SUBCO TOC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2016Data di scioglimento
    10 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0