ASCRIBE HOLDINGS LIMITED

ASCRIBE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASCRIBE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05204003
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fulford Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASCRIBE HOLDINGS PLC20 feb 200920 feb 2009
    ASCRIBE PLC25 nov 200425 nov 2004
    ASCRIBE LIMITED19 nov 200419 nov 2004
    EVER 2458 LIMITED12 ago 200412 ago 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Stato del capitale al 10 ott 2022

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 24/08/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Capitalise £6190104 23/08/2022
    RES14

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 ago 2022

    • Capitale: GBP 7,407,275.61
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England a Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagineAD04

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagineAD04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Scroll Bidco Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2019

    2 paginePSC05

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Rawdon House Green Lane Yeadon Leeds LS19 7BY a Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA in data 02 dic 2019

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENSON, Christine
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Segretario
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    239348480001
    SOUTHBY, Peter John
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Amministratore
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish116859780002
    STEWART, Paul
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Amministratore
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish262072580001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Segretario
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    192309700001
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Segretario
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    Segretario
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    166860890001
    WAITE, Simon Nicholas
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Segretario
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    213729210001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    BARBER, Dean Anthony
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Amministratore
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    EnglandBritish230739040001
    CRITCHLOW, Anthony Stephen
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    Amministratore
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    United KingdomBritish101716720002
    DICKSON, Christopher John
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    Amministratore
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    EnglandBritish100748280003
    HUGHES, David Michael
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    Amministratore
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    EnglandBritish12292930002
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Amministratore
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    United KingdomBritish98814590001
    LEWIS, Graham Robert
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    British117396680001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish34428100003
    PRIESTNER, Ian
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish114678190001
    SPENCER, Christopher Michael Kennedy
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Amministratore
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish4742550002
    TAMBLYN, Christina
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Amministratore
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish191028210001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Amministratore
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    EnglandBritish154577090001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASCRIBE HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    06 apr 2016
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06724468
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 01 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Eci Ventures Nominees Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 01 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage over stocks and shares by owner to secure own account
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 01 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stocks shares and other marketable securities being 1 arkive computing limited (company number 4611493) ordinary, 292,886,176 ascribe limited (formerly known as asc computer software limited (company number 2394847) ordinary, 100 barwick systems limited (company number 1756830) ordinary see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of contracts
    Creato il 10 mag 2006
    Consegnato il 27 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the rights and powers under the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0