CONISTON DAC LIMITED

CONISTON DAC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONISTON DAC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05207570
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONISTON DAC LIMITED?

    • Concessione di credito da parte di istituti finanziari non depositari e altri concedenti specializzati di credito al consumo (64921) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CONISTON DAC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kroll Advisory Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONISTON DAC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMMERCIAL FIRST DAC LTD29 set 200429 set 2004
    CHELTRADING 387 LIMITED17 ago 200417 ago 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONISTON DAC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per CONISTON DAC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Glos GL50 3WG a Kroll Advisory Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 01 lug 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 giu 2021

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 052075700012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 052075700013 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Commercial First Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Fraser Stewart Barbour come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2018

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 nov 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 nov 2016

    15 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 set 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 set 2016

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 nov 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2015

    Stato del capitale al 17 ago 2015

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2014

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Anuj Nehra come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 052075700014 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CONISTON DAC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THEOBALD, Timothy Paul
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    165594800001
    NEPTUNE SECRETARIES LIMITED
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    Segretario
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    84239630002
    THEOBALD, Timothy Paul
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant164213700002
    MILLWARD, Keith Roger
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    158221160001
    RUSHBROOK, Daniel James
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    British101042310002
    RUSHBROOK, Daniel James
    28 Broadwater Avenue
    SG6 3HF Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    28 Broadwater Avenue
    SG6 3HF Letchworth
    Hertfordshire
    British101042310001
    SCALES, Eugene Patrick
    10 Fisher Court
    Rhapsody Crescent
    CM14 5GE Brentwood
    Essex
    Segretario
    10 Fisher Court
    Rhapsody Crescent
    CM14 5GE Brentwood
    Essex
    Other124193970001
    BARBOUR, John Fraser Stewart
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director160906180001
    GEORGE, Philip Anthony
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131304410001
    JOHNSON, Alec David
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director103446140001
    MILLWARD, Keith Roger
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant80388420001
    NEHRA, Anuj
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector119449420001
    PARROTT, Marc Richard
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector30126180002
    STOORNE INCORPORATIONS LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002940001
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CONISTON DAC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Commercial First Group Limited
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    06 apr 2016
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneThe Registar Of Companies In The United Kingdom
    Numero di registrazione04461471
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CONISTON DAC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2014
    Consegnato il 03 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cvic Lux Master S.a R.L.
    • Cvf Lux Master S.a R.L
    • Cvi Cvf Ii Master S.a R.L.
    Transazioni
    • 03 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2014
    Consegnato il 02 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2013
    Consegnato il 20 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 21 gen 2011
    Consegnato il 04 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and ilford funding limited to the secured creditors on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights, claims, title, benefit and interest present and future in each securitisation document and each custody agreement and all rights, title and interest in and to the detachable a coupons, the mercs and the residual revenue see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skipton Building Society
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Overriding deed of amendment and guarantee
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bmf 2 deed of charge, bmf 3 deed of charge, bmf 4 deed of charge by way of security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of the rights claims title benefit and interest present and future in each of the securitisation documents and the custody agreement together with the right to all monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Overriding deed of amendment and guarantee
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 24 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bmf 2 deed of charge, bmf 3 deed of charge, bmf 4 deed of charge, each being provided as security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 26 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights, claims, title, benefit and interest present and future in each of the securitisation documents and the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 12 apr 2006
    Consegnato il 25 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights claims title benefit and interest present and future in each of the securitisation documents and the custody agreement together with the right to all monies payable and all the rights of action thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 19 lug 2005
    Consegnato il 26 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest in each of the securitisation documents the custody agreement together with all monies payable to the borrower the dacs the mercs the residual revenue the collaterral account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 18 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The pledgor pledged the securities being the detachable a coupons and the mercs. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights,claims,title,benefit and interest present and future in each of the securitisation documents and the custody agreement together with the right to all monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CONISTON DAC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2021Inizio della liquidazione
    04 ago 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Robert Bines
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Matthew Ingram
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Praticante
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0