CARDSAVE HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARDSAVE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05207657 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Parkway Offices Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby South Humberside |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BROOMCO (3521) LIMITED | 17 ago 2004 | 17 ago 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 31 gen 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Patrick O'keefe come amministratore in data 14 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanna Mary Baker come amministratore in data 14 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Stephen Wilson come amministratore in data 14 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Frank Paul Christian D'hollander come amministratore in data 12 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Mark Dann come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Mark Dann come segretario in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Mark Dann il 17 ott 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Anthony Mark Dann il 17 ott 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Clive Kahn come amministratore in data 01 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 55 Mansell Street London E1 8AN a Walbrook Building Walbrook London EC4N 8AF | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Aidan Connolly come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ron Kalifa come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Frank D'hollander come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Arthur Hobday come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Stephen Wilson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darren Wilson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, Joanna Mary | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | England | British | 248233600001 | |||||
| HOBDAY, David Arthur | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | England | British | 186436550001 | |||||
| O'KEEFE, Kevin Patrick | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | England | American | 203583750001 | |||||
| DANN, Anthony Mark | Segretario | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | British | 96438940006 | ||||||
| POPPLETON, Gareth David | Segretario | The Cottage Conisholme Road North Somercotes LN11 7PS Louth Lincolnshire | British | 57603080001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BENTHAM, Paul Gerald | Amministratore | Villa Franove, 43 Avenue Des Bosquets-De-Julie Clarens Montreux 1815 Switzerland | Switzerland | British | 103837360001 | |||||
| CONNOLLY, Aidan Joseph | Amministratore | 55 Mansell Street E1 8AN London Worldpay England | England | British | 100376210001 | |||||
| D'HOLLANDER, Frank Paul Christian | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | Belgium | Belgian | 177967690001 | |||||
| DANN, Anthony Mark | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside | United Kingdom | British | 96438940008 | |||||
| DILLON, John Eamon | Amministratore | The Hey House Lapworth Street Lapworth B94 5QF Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 54871970006 | |||||
| HART, Stephen Andrew | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | Scotland | British | 157053520001 | |||||
| JOHNSON, Duncan Edward | Amministratore | Baigens Winchester Road GU34 1SL Chawton Hampshire | United Kingdom | British | 266556880001 | |||||
| KAHN, Clive Ian | Amministratore | 8 Turner Drive NW11 6TX London | England | British | 124009130001 | |||||
| KALIFA, Ron | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | 106749110001 | |||||
| KANTER, Ralph Thomas Ludwig | Amministratore | Garden Flat 17 Upper Park Road NW3 2UN London | United Kingdom | British | 124153720001 | |||||
| ORMONDE, James | Amministratore | Brickyard Farm Rasen Rooad DN21 4RN Waddingham Lincolnshire | England | British | 163350780001 | |||||
| POPPLETON, Gareth David | Amministratore | The Cottage Conisholme Road North Somercotes LN11 7PS Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 57603080001 | |||||
| RIGGALL, Jonathan | Amministratore | 2 Tennyson Street LE19 3FD Narborough Leicestershire | England | British | 103969910001 | |||||
| RYDER, Ian Bernard | Amministratore | 45 Clematis Avenue Healing DN41 7JJ Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 84313960003 | |||||
| WILSON, Darren | Amministratore | 55 Mansell Street E1 8AN London Worldpay England | England | British | 113021310001 | |||||
| WILSON, David Stephen | Amministratore | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside United Kingdom | England | British | 100909000001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARDSAVE HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardsave Acquisitions Limited | 06 apr 2016 | Acorn Business Park, Moss Road DN32 0LW Grimsby Parkway Offices South Humberside England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
CARDSAVE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 09 ago 2007 Consegnato il 28 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moniees due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 ott 2004 Consegnato il 09 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and to the security beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0