SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05207664 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BROOMCO (3523) LIMITED | 17 ago 2004 | 17 ago 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2023 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2024 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Victoria Louise De Temple come amministratore in data 11 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG in data 03 lug 2024 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Michael Taylor come amministratore in data 19 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan James Goodson come amministratore in data 17 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Helen Potter come amministratore in data 21 giu 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Aviva Company Secretarial Services Limited il 27 mar 2024 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Victoria Louise De Temple come amministratore in data 10 set 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Rippon come amministratore in data 05 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Michael Taylor come amministratore in data 24 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan James Goodson come amministratore in data 24 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
POTTER, Helen | Amministratore | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British,German | Director | 274114750001 | ||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||
JC SECRETARIES LIMITED | Segretario | 55 King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor | 86092550003 | |||||||||||
DE TEMPLE, Victoria Louise | Amministratore | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Company Secretary | 287474690001 | ||||||||
GOODSON, Jonathan James | Amministratore | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 | United Kingdom | British | Accountant | 243076880001 | ||||||||
KANERICK, Robert Philip | Amministratore | 201 Goldhurst Terrace NW6 3ER London | England | British | Director | 64145800001 | ||||||||
PRICE, Jonathan Stewart | Amministratore | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 Uk | England | British | None | 258221020001 | ||||||||
RIPPON, Nigel Lee | Amministratore | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 | United Kingdom | British | Accountant | 205870560001 | ||||||||
RIX, Lindsey Claire | Amministratore | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 Uk | United Kingdom | British | None | 192908590003 | ||||||||
TAGLIAFERRI, Mark Lee | Amministratore | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | England | British | Director | 106792270001 | ||||||||
TAYLOR, Peter Michael | Amministratore | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 | United Kingdom | British | Director | 275443370001 | ||||||||
WHITTON, Robert David | Amministratore | Fencepiece Road IG7 5DY Chigwell 382 Essex | United Kingdom | British | Director | 140499650001 | ||||||||
DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Insurance Limited | 06 apr 2016 | PH2 0NH Perth Pitheavlis Perthshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 10 mar 2006 Consegnato il 30 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 mar 2006 Consegnato il 28 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H land k/a broadlands phase 1 horizon business centre peacham way broadland business park thorpe norwich t/no NK315468 by way of security assignment the insurances. By way of floating charge all assets property and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 set 2004 Consegnato il 15 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property being the l/h land known as broadlands phase 1 horizon business centre peacham way broadland business park thorpe norwich,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 set 2004 Consegnato il 14 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property being the l/h land known as broadlands phase 1 horizon business centre peacham way broadland business park thorpe norwich, including the insurances, floating charge all assets property and undertaking present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SYNERGY SUNRISE (BROADLANDS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0