NEOS RESOURCES PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEOS RESOURCES PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 05212852
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEOS RESOURCES PLC?

    • Commercio all'ingrosso di altri combustibili e prodotti connessi (46719) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NEOS RESOURCES PLC?

    Indirizzo della sede legale
    55 Gower Street
    WC1E 6HQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEOS RESOURCES PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    D1 OILS PLC24 set 200424 set 2004
    D1 PLC31 ago 200431 ago 2004
    PINCO 2191 PLC24 ago 200424 ago 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEOS RESOURCES PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per NEOS RESOURCES PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Gordon Richard Tainton come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Conrad Baeschlin Moquette come amministratore in data 06 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominic Traynor come segretario in data 20 mar 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Russel William Thomson come amministratore in data 20 mar 2017

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ago 2016 con aggiornamenti

    28 pagineCS01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 24 ago 2015

    23 pagineRP04AR01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2015

    45 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gordon Richard Tainton il 18 mar 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Conrad Baeschlin Moquette il 18 mar 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 05 nov 2015

    • Capitale: GBP 178,315,219
    SH01
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 16 nov 2016

    • Capitale: GBP 1,783,152.19
    SH01
    Note
    DataNota
    16 nov 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 16/11/2016

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Northern House Woodsome Park Fenay Bridge Huddersfield Yorkshire HD8 0LA a 55 Gower Street London WC1E 6HQ

    1 pagineAD02

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2014

    50 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 55 Gower Street London WC1E 6HQ

    2 pagineAD04

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2014

    Stato del capitale al 17 dic 2014

    • Capitale: GBP 178,315,219
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 27/28 Eastcastle Street, London, W1W 8DH, England a 55 Gower Street London WC1E 6HQ in data 16 dic 2014

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Marie Elizabeth Edwards come segretario in data 28 ott 2014

    2 pagineTM02

    Nomina di Dominic Traynor come segretario in data 28 ott 2014

    3 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di NEOS RESOURCES PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEANE, Timothy William Melford
    22 Gleeson Mews
    KT15 2BG Addlestone
    Surrey
    Segretario
    22 Gleeson Mews
    KT15 2BG Addlestone
    Surrey
    British118833080001
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    1 Woodlands
    AL5 3BY Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Woodlands
    AL5 3BY Harpenden
    Hertfordshire
    British122911720001
    GUDGEON, Richard Keith
    26 Bernica Grove
    TS17 0FR Ingleby Barwick
    Cleveland
    Segretario
    26 Bernica Grove
    TS17 0FR Ingleby Barwick
    Cleveland
    British110379200001
    MANNIS, Elliott Michael
    63
    Station Road
    PE28 0PE Catworth
    Hunters Drift
    Huntingdon
    Uk
    Segretario
    63
    Station Road
    PE28 0PE Catworth
    Hunters Drift
    Huntingdon
    Uk
    British139879240001
    TRAYNOR, Dominic
    Gower Street
    WC1E 6HQ London
    55
    Uk
    Segretario
    Gower Street
    WC1E 6HQ London
    55
    Uk
    British123408450001
    WORRALL, Alex David
    Low Walworth Hall
    Walworth
    DL2 2NA Darlington
    County Durham
    Segretario
    Low Walworth Hall
    Walworth
    DL2 2NA Darlington
    County Durham
    British44246150001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BLACK, Moira Elizabeth
    60 Beaufort Road
    W5 3EA London
    Amministratore
    60 Beaufort Road
    W5 3EA London
    EnglandBritish6222570001
    CAMPBELL, William Peter
    Norwood House
    76 Abbey Road
    DL3 8NN Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Norwood House
    76 Abbey Road
    DL3 8NN Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish100508560001
    DAVIDSON, Peter John
    1 Mill Cottages
    Mill Road
    IM9 2EG Ballasalla
    Isle Of Man
    Amministratore
    1 Mill Cottages
    Mill Road
    IM9 2EG Ballasalla
    Isle Of Man
    British100508190002
    DOUTY, Stephen Peter
    Turftide
    Icehouse Wood
    RH8 9DN Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Turftide
    Icehouse Wood
    RH8 9DN Oxted
    Surrey
    EnglandBritish68353760001
    FORREST, John Barclay
    Horncliffe Gardens
    Horncliffe
    TD15 2XW Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Amministratore
    Horncliffe Gardens
    Horncliffe
    TD15 2XW Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    United KingdomBritish296680002
    GOOD, Benjamin Richard
    Granhams Road
    CB22 5JX Great Shelford
    Shepherds Cottage 26
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Granhams Road
    CB22 5JX Great Shelford
    Shepherds Cottage 26
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish130903800001
    GUDGEON, Richard Keith
    26 Bernica Grove
    TS17 0FR Ingleby Barwick
    Cleveland
    Amministratore
    26 Bernica Grove
    TS17 0FR Ingleby Barwick
    Cleveland
    EnglandBritish110379200001
    JARVIS, Martin John
    The Street
    Ulcombe
    ME17 1DP Maidstone
    Candle Cottage
    Amministratore
    The Street
    Ulcombe
    ME17 1DP Maidstone
    Candle Cottage
    EnglandBritish124386950001
    JOOS, Henk
    A L Huxleystraat 43
    Bellem
    B9881
    Belgium
    Amministratore
    A L Huxleystraat 43
    Bellem
    B9881
    Belgium
    BelgiumBelgian119861480001
    JOSE, Ravi Varkey
    Chemin Colladon
    1209
    18
    Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    Chemin Colladon
    1209
    18
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss171040430001
    KEIL, Alastair Duncan
    10 Route De Geneve
    1033 Cheseaux
    Le Chateau
    Switzerland
    Amministratore
    10 Route De Geneve
    1033 Cheseaux
    Le Chateau
    Switzerland
    SwitzerlandBritish183575590001
    LEAVER, Christopher John, Professor
    Glebe House 51 Church Lane
    Old Marston
    OX3 0PT Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Glebe House 51 Church Lane
    Old Marston
    OX3 0PT Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish51604210001
    MANNIS, Elliott Michael
    63
    Station Road
    PE28 0PE Catworth
    Hunters Drift
    Huntingdon
    Uk
    Amministratore
    63
    Station Road
    PE28 0PE Catworth
    Hunters Drift
    Huntingdon
    Uk
    United KingdomBritish139879240001
    MOQUETTE, Michael Conrad Baeschlin
    Route Du Vallon
    1224 Geneva 1224
    Le Peiti Vallon 40
    Switzerland
    Switzerland
    Amministratore
    Route Du Vallon
    1224 Geneva 1224
    Le Peiti Vallon 40
    Switzerland
    Switzerland
    SwitzerlandDutch And Canadian169037920002
    MORTON, Clive Neil, Dr
    240 Eastfield Road
    PE1 4BD Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    240 Eastfield Road
    PE1 4BD Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish1744240002
    MYERSON, Brian Alan
    14 Quai Du General Guisan
    Geneva 1204
    14
    Switzerland
    Amministratore
    14 Quai Du General Guisan
    Geneva 1204
    14
    Switzerland
    South African108205540004
    MYERSON, Nicholas Paul
    28 Chemin De La Tinte
    1936 Verbier
    Apartment 17
    Switzerland
    Switzerland
    Amministratore
    28 Chemin De La Tinte
    1936 Verbier
    Apartment 17
    Switzerland
    Switzerland
    SwitzerlandSouth African165887760003
    OXBURGH, Ernest Ronald, Lord
    14 Bentley Road
    CB2 8AW Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    14 Bentley Road
    CB2 8AW Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish116247330001
    QUINN, Mark Lockhart Muir
    1 St Botolphs Court
    St Botolphs Road
    TN13 3AS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    1 St Botolphs Court
    St Botolphs Road
    TN13 3AS Sevenoaks
    Kent
    British79406570004
    RUDOFSKY, Steven Zachariah
    Ranulf Road
    NW2 2BT London
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Ranulf Road
    NW2 2BT London
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritish53323380002
    TAINTON, Gordon Richard
    Ch-1162
    1162 St.Prex
    Ch. De Senaugin 11
    Switzerland
    Amministratore
    Ch-1162
    1162 St.Prex
    Ch. De Senaugin 11
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss183330460002
    TAWNEY, Christopher
    The White House
    Easton Royal
    SN9 5LY Pewsey
    Wiltshire
    Amministratore
    The White House
    Easton Royal
    SN9 5LY Pewsey
    Wiltshire
    United KingdomBritish73572700001
    THOMSON, Russel William
    Challenge Place
    WA6021 Balcatta
    14
    Australia
    Amministratore
    Challenge Place
    WA6021 Balcatta
    14
    Australia
    AustraliaAustralian191231330001
    WARD, Charles John Nicholas
    Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Bacon House
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Bacon House
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78441480001
    WATKIN, Karl Eric
    Ghylleheugh
    Longhorsley
    NE65 8RF Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Ghylleheugh
    Longhorsley
    NE65 8RF Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish36688560001
    WOOD, Philip Kenneth
    4 Middlings Wood
    Kippington Road
    TN13 2LF Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    4 Middlings Wood
    Kippington Road
    TN13 2LF Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish8259380001
    WOOLFMAN, Graham Jeffrey
    Wigmore Street
    W1U 1AU London
    33
    England
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1AU London
    33
    England
    United KingdomBritish66067170001

    NEOS RESOURCES PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re D1 oils PLC current account. Account number 23133958. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 14 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent security deed
    Creato il 05 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £18,506.25.
    Persone aventi diritto
    • Grammont Properties Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent security deed
    Creato il 05 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £41,125.
    Persone aventi diritto
    • Grammont Properties Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0