KBC HARROW LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKBC HARROW LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05214729
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KBC HARROW LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KBC HARROW LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor, 2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KBC HARROW LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per KBC HARROW LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Burwood Place London W2 2UT England a 6th Floor, 2 Kingdom Street London W2 6BD in data 14 ago 2023

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Oliver Loh come amministratore in data 12 mag 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 052147290007, creata il 31 dic 2020

    32 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 052147290006, creata il 20 ott 2020

    4 pagineMR01

    Nomina di Mr Simon Oliver Loh come amministratore in data 06 feb 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Peter David Edward Gibson come amministratore in data 28 ott 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    legacy

    10 pagineRP04CS01

    Cessazione di Kbc Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 ott 2016

    1 paginePSC07

    Notifica di Iwg Plc come persona con controllo significativo il 19 dic 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    Note
    DataNota
    29 set 2017Clarification A second filed CS01 (Shareholder Information and Information about people with significant control) was registered on 29/09/2017.

    Chi sono gli amministratori di KBC HARROW LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORRIS, Richard
    2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    6th Floor,
    England
    Amministratore
    2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    6th Floor,
    England
    EnglandBritish190653350001
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Segretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183191770001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Segretario
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    CORT, Louise
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    Segretario
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    British84863600003
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Segretario
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    185457880001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Segretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    154659950001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    GIBSON, Peter David Edward
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Amministratore
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    KINGSHOTT, Michael James
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish83713020002
    LOH, Simon Oliver
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Amministratore
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    United KingdomBritish197301770002
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    PRINGLE, Aileen
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    Amministratore
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    United KingdomBritish764870001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Amministratore
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    EnglandBritish154659960001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KBC HARROW LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Iwg Plc
    Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    22
    Jersey
    19 dic 2016
    Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    22
    Jersey
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneJersey
    Autorità legaleCompanies (Jersey) Law 1991
    Luogo di registrazioneJfsc Companies Registry
    Numero di registrazione122154
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Regus Plc
    Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    22
    31 ott 2016
    Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    22
    Forma giuridicaPiblic Limited Company
    Paese di registrazioneJersey
    Autorità legaleCompanies (Jersey) Law 1991
    Luogo di registrazioneJfsc Companies Registry
    Numero di registrazione101523
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Kbc Holdings Limited
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    06 apr 2016
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    KBC HARROW LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 dic 2020
    Consegnato il 18 gen 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Genesis Finance S.a R.L.
    Transazioni
    • 18 gen 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2020
    Consegnato il 27 ott 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pathway Finance Sarl
    Transazioni
    • 27 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    2 gayton road, middlesex t/no NGL571767 by way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. 2 grayton road, middlesex t/no NGL571767 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 28 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Persone aventi diritto
    • West Register Number 2 Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 gayton road,harrow t/no NGL571767. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 ott 2004
    Consegnato il 28 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0