KBC KINGSTON LIMITED

KBC KINGSTON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKBC KINGSTON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05214860
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KBC KINGSTON LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova KBC KINGSTON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KBC KINGSTON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KBC KINGSTON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KBC KINGSTON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Lyric Square London W6 0NB England a 268 Bath Road Slough SL1 4DX in data 23 apr 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Richard Morris come amministratore in data 10 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter David Edward Gibson come amministratore in data 10 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael James Kingshott come amministratore in data 10 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marie Elizabeth Edwards come segretario in data 10 apr 2015

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 22 Long Acre London WC2E 9LY a 268 Bath Road Slough SL1 4DX in data 26 nov 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Nomina di Mrs Marie Elizabeth Edwards come segretario in data 18 dic 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Paul Alexander come segretario in data 18 dic 2013

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Paul Alexander come amministratore in data 17 ott 2013

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Alexander come segretario in data 17 ott 2013

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Alan Douglas Pepper come amministratore in data 17 ott 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Jane Scannell come amministratore in data 17 ott 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Jane Scannell come amministratore in data 17 ott 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Jane Scannell come segretario in data 17 ott 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Serviced Office Group 22 Long Acre London WC2E 9LY England in data 29 ago 2013

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di KBC KINGSTON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Segretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183186590001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Segretario
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    CORT, Loiuse
    7a Ellerton Road
    SW18 3NG London
    Segretario
    7a Ellerton Road
    SW18 3NG London
    British99786980001
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Segretario
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    185459130001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Segretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    154661320001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    KINGSHOTT, Michael James
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Amministratore
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    EnglandBritish83713020002
    PRINGLE, Aileen
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    Amministratore
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    United KingdomBritish764870001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Amministratore
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    EnglandBritish154659960001

    KBC KINGSTON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 11 feb 2013
    Consegnato il 12 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    20 canbury passage kingsgate road surrey t/no SY279853 together with all fixtures & fittings, now or at any time hereafter, on the property. The benefits of all rights, licences & the goodwill of the mortgagor in relation to the business, from time to time, carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Canbury passage, kingsgate road, surrey t/no's SY327216, SG1254907, SGL124369 and SGL58811. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Canbury passage, kingsgate road, surrey t/no's SY327216, SGL1254907, SGL124369 and SGL58811 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 28 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Persone aventi diritto
    • West Register Number 2 Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 12-50 kingsgate road,kingston t/no's SY279853,SY327216,SGL254907,SGL124369 and SGL58811. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 ott 2004
    Consegnato il 28 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0