PIMS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPIMS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05280931
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PIMS GROUP LIMITED?

    • Fognatura (37000) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova PIMS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Private Road No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PIMS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3609) LIMITED09 nov 200409 nov 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di PIMS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PIMS GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PIMS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Karen Linda Pay come amministratore in data 20 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephane Rousselot come amministratore in data 28 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Grund come amministratore in data 11 set 2015

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Melanie Linda Sowter come segretario in data 31 mar 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Melanie Linda Sowter come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 30 lug 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 gen 2015

    Stato del capitale al 09 gen 2015

    • Capitale: GBP 554,545.43
    SH01

    Nomina di Mrs Karen Linda Pay come amministratore in data 27 nov 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert Grund come amministratore in data 27 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter John Lewington come amministratore in data 27 nov 2014

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 ott 2014

    • Capitale: GBP 554,545.45
    4 pagineSH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 nov 2014

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 17/10/2014
    RES13

    Bilancio redatto al 31 lug 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2013

    Stato del capitale al 16 dic 2013

    • Capitale: GBP 554,545.43
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2013 al 31 lug 2013

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Charles White come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hants GU14 8JE* in data 29 ago 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Michael Bell come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Melanie Linda Sowter come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di PIMS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROUSSELOT, Stephane
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Amministratore
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandFrench202797810001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    Segretario
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    British101749180003
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Segretario
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    British90062470004
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    Segretario
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    Irish84925400001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Segretario
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    179710270001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    Amministratore
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    EnglandBritish101749180003
    BANKS, Francis Wilson
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    GU14 8JE Hants
    Amministratore
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    GU14 8JE Hants
    United KingdomBritish152084560001
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish90062470004
    CANNING, Paul
    20 Mascotte Road
    Putney
    SW15 1NN London
    Amministratore
    20 Mascotte Road
    Putney
    SW15 1NN London
    British109698250001
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    Amministratore
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    United KingdomIrish84925400001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Amministratore
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    GRUND, Robert
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Amministratore
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandAustrian182385330001
    LAWRENCE, Kenneth William
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    Amministratore
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    United KingdomBritish40388380001
    LEWINGTON, Peter John
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Amministratore
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritish137420410001
    PAY, Karen Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Amministratore
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandBritish176337440001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Amministratore
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritish113352030002
    TAYLOR, Brian Thomas
    Spring Lodge
    Hook Heath
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    Amministratore
    Spring Lodge
    Hook Heath
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    British86150710002
    WHITE, Charles Liddell
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    Amministratore
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    EnglandBritish54824060001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    PIMS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A guarantee and security agreement
    Creato il 07 apr 2009
    Consegnato il 17 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transazioni
    • 17 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A master guarantee and security
    Creato il 11 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 11 mar 2008
    Consegnato il 20 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of its stock,shares,bonds,debentures,debenture stock,loan stock,unit trust investments,certificates of deposit and other securities of any description see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the subsidiaries to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham LLP as Trustee for Itself and the Registered Holders from Time to Time of Notes Issuedunder the Gresham Loan Note Instrument (In Suchcapacity, the Trustee)
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of life policy
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The keyman policy in respect of charles white dated 3 december 2004 issued by friends provident life and pensions with policy number Q2851614 in respect of critical illness and disability and st james's place UK PLC with policy number 45C16M98 in respect of life cover and any other policy or policies required to be effected by the charge together with the rights and benefits accrued or accruing under these policies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0