ASHBOURNE BOSS LIMITED

ASHBOURNE BOSS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHBOURNE BOSS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05282592
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHBOURNE BOSS LIMITED?

    • Attività delle case di cura mediche (86102) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ASHBOURNE BOSS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE BOSS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE BOSS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 31 ago 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Charles Lovett come amministratore in data 31 ago 2012

    2 pagineAP01

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 dic 2011

    Stato del capitale al 06 dic 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE BOSS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Amministratore
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British96974070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304860001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Anne
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish118289800001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COUSINS, Carol
    Crumlin Road
    Ballinderry Upper
    BT28 2JX Lisburn
    26
    County Antrim
    Amministratore
    Crumlin Road
    Ballinderry Upper
    BT28 2JX Lisburn
    26
    County Antrim
    Northern IrelandBritish249170210001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Amministratore
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritish130867640001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAINES, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Amministratore
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    British89071020003
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MACINTOSH, Michael
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish137864880001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish91088900004
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Amministratore
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Amministratore
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Amministratore
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ASHBOURNE BOSS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as chester housecare centre 8/10 third avenue sherwood R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as nightingale court 11 to 14 comberton road kidderminste. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as burgh hall hall lane skegness lincolnshire t/n LL24913. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as stafford HALL138-140 thundersley park road south benf. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as stafford court care centre venables close canvey islan. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as st paul's nursing home high street waddington lincoln,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as sampford house 27 shurnold melsham wiltshire t/n WT234. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Properties Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 6 july 2005 and
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Lease between cannon capital boss limited and ashbourne boss limited dated 28 june 2005 k/a muirton house nursing home essendy road blairgowrie t/no PTH25285.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 mag 2005
    Consegnato il 20 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the l/h estates being, l/h property k/a great horkesley manor, nayland road, great horkesley, colchester. T/no EX445283 including all fixtures, all proceeds of sale, all proceeds of any insurance and the benefit of all covenants, future rights, other rights under operating lease, contracts, book debts, cash receipts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 20 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 mag 2005
    Consegnato il 20 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all rights relating to the property being, l/h property k/a nayland house, bear street, nayland, colchester. T/no SK190856 and SK200198 including all fixtures, all proceeds of sale, all proceeds of any insurance, the benefit of all covenants, future rights, other rights under operating lease, contracts, book debts, cash receipts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 20 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 23 february 2005 and
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lease of the subjects known as and forming broomfield nursing home broomfield road glasgow t/n GLA122661.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 25 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property, assets and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 25 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 07 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dunnaney, 12 glebe road, carnmoney, newtownabbey, county antrim; glebe, 2 glebe road, carnmoney, newtownabbey, county antrim; kingsland 252 seacliff road, bangor county down. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Boss Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 nov 2004
    Consegnato il 03 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal charged property being melmount manor, 1 orchard road, strabane; culmore manor nursing home, 39 culmore road, londonderry; greenhaw lodge, 42 racecourse road, londonderry; templemoyle private nursing home, 41A whitehall road, eglinton, county londonderry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Capital Funding Boss Limited
    Transazioni
    • 03 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASHBOURNE BOSS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0