CISION UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCISION UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05297089
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CISION UK LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova CISION UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CISION UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROMEIKE LIMITED07 gen 200507 gen 2005
    ROMEIKE MEDIA LIMITED16 dic 200416 dic 2004
    TRUSHELFCO (NO.3117) LIMITED26 nov 200426 nov 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di CISION UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CISION UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 04 lug 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 14 dic 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 ott 2021

    7 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Soddisfazione dell'onere 052970890004 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 052970890003 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 052970890006 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 052970890005 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 ott 2020

    6 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place London E14 5HU England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 01 nov 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 ott 2019

    LRESSP

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 set 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 31 gen 2019

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CISION UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AKEROYD, Kevin
    East Randolph Street
    Suite 700
    Chicago
    130
    Illinois 60601
    United States
    Amministratore
    East Randolph Street
    Suite 700
    Chicago
    130
    Illinois 60601
    United States
    United StatesAmericanCeo213466620001
    PEARLSTEIN, Jacob
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United StatesAmericanChief Financial Officer195105580001
    CULLEN, Andrew Arthur
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    Segretario
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishDirector74625030001
    FAUTLEY, Mark Stephen
    25 Barge Walk,
    SE10 0FN London,
    Flat 132,
    United Kingdom
    United Kingdom
    Segretario
    25 Barge Walk,
    SE10 0FN London,
    Flat 132,
    United Kingdom
    United Kingdom
    188160810001
    HEAD, Andrew James
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector115498340001
    KENT, Samantha
    3 White Hill
    Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    3 White Hill
    Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    British118954610001
    KIMBER, Rachel Natasha
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    146561610001
    MACKENZIE, Cameron
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Segretario
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishFinance Director49484390001
    RITCHIE, Thomas David
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    177427570001
    WHEELER, Kevin
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Segretario
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    181952140001
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Segretario nominato
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    BLANDY, Yann
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    SwedenFrenchEuropean Ceo161276220001
    BODIE, Giselle Lillian
    High Orchard
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    High Orchard
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director65078960002
    BRUCE-MORGAN, Torsten Morris Tomas
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    EnglandBritishEuropean Cfo93435540002
    CULLEN, Andrew Arthur
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Hamilton Road
    WD4 8PY Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishDirector74625030001
    FORSBERG, Erik
    Vikingav 10 B
    Djorsholm
    18263
    Sweden
    Amministratore
    Vikingav 10 B
    Djorsholm
    18263
    Sweden
    SwedenSwedishC F O138693950001
    GRANAT, Peter Wruble
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    Amministratore
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    Illinois, UsaBritishCeo309583160001
    GRANAT, Peter Wruble
    King Henrys Road
    Primrose Hill
    NW3 3QP London
    Flat 5, 5
    Amministratore
    King Henrys Road
    Primrose Hill
    NW3 3QP London
    Flat 5, 5
    United KingdomUnited StatesCeo Europe138694710001
    HANSSON, Nina Charlotte Vithlani
    Linnegatan
    PO BOX 24194
    104 51 Stockholm
    87a
    Sweden
    Amministratore
    Linnegatan
    PO BOX 24194
    104 51 Stockholm
    87a
    Sweden
    SwedenSwedishChief Financial Officer182693150001
    HEAD, Andrew James
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Grove End
    AL5 1JU Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector115498340001
    HIGGINS, Michael Andrew
    Buttonwood
    Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    Amministratore
    Buttonwood
    Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    EnglandBritishDirector116898590001
    KELLY, Joel John
    8 Patagonia House
    Pembury Road
    TN2 3DL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    8 Patagonia House
    Pembury Road
    TN2 3DL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishSolicitor102030600001
    KELLY, Leslie George Edwin
    169 Priests Lane
    CM15 8LF Shenfield
    Essex
    Amministratore
    169 Priests Lane
    CM15 8LF Shenfield
    Essex
    BritishDirector76315400002
    KENT, Samantha Jane
    Woodcroft
    3 White Hill Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodcroft
    3 White Hill Flamstead
    AL3 8DN St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director181522870001
    KIMBER, Rachel Natasha
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    United KingdomBritishFinance Director151204940001
    MACKENZIE, Cameron
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Roseacres
    CM21 0BU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director49484390001
    MUNIER, Marc Andrew James
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    EnglandBritishDirector135852000002
    PALFREEMAN, Neil
    White Cottage Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DZ Great Missenden
    Bucks
    Amministratore
    White Cottage Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DZ Great Missenden
    Bucks
    EnglandBritishDirector33210210001
    POWELL, Stephen Robert Bradley
    The Apple House 3 Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    Amministratore
    The Apple House 3 Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    BritishSolicitor47611950002
    RITCHIE, Thomas
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    Amministratore
    16-22 Baltic Street West
    EC1Y 0UL London
    Cision House
    England
    United KingdomBritishManaging Director168336560001
    ROTHERY, Andrew Paul
    Walters Farm
    Sandy Lane, Tiddington
    OX9 2LE Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    Walters Farm
    Sandy Lane, Tiddington
    OX9 2LE Thame
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector102257490001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Amministratore
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    BritishDirector96079800001
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishCompanysecretary61053330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CISION UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cision Ltd
    Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    Georgetown
    Walkers Corporate Ltd
    Cayman Islands
    29 giu 2017
    Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    Georgetown
    Walkers Corporate Ltd
    Cayman Islands
    No
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleCayman Islands Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    06 apr 2016
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3858850
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    06 apr 2016
    28-42 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Discovery House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione9062485
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CISION UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 gen 2018
    Consegnato il 25 gen 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3(h) of the instrument, the company charged by way of first fixed charge all its present and future right, title and interest in and to all material intellectual property, including a trademark with registered number 1290199 named “willings". For further details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as the Security Trustee
    Transazioni
    • 25 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 set 2017
    Consegnato il 28 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3(h) of the instrument, the company charged by way of first fixed charge all its present and future right, title and interest in and to all material intellectual property, including a trademark with registered number 1290199 named “willings". For further details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as the Security Trustee
    Transazioni
    • 28 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2016
    Consegnato il 29 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3 of the debenture, the company has charged by way of fixed charge all its present and future material intellectual property and all related rights, including, without limitation, the UK trademark with registered number 1290199 named “willings”. For further details, please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2016
    Consegnato il 28 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3 of the debenture, the company has charged by way of first fixed charge all its present and future material intellectual property and all related rights, including, without limitation, the UK trademark with registered number 1290199 named “willings”. For further details, please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 13 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jefferies Finance Llc as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 giu 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 13 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jefferies Finance Llc as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 giu 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CISION UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ott 2019Inizio della liquidazione
    11 nov 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0