RIPSHORE PROPERTIES LIMITED

RIPSHORE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIPSHORE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05307707
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ashley House
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Surrey
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 mar 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Johnson come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Joanne Elizabeth Massey come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del segretario cambiati per Robin Simon Johnson il 24 nov 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 13 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Dominic Joseph Lavelle il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 nov 2006

    • Capitale: GBP 500,002
    2 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2008 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147807860001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    BROWN, Carole Elizabeth
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British98235420001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    FORBES SECRETARIES LIMITED
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    Segretario
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    67773790001
    BROWN, Carole
    2 Fox Hedge Way
    Sharnbrook
    MK44 1JR Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Fox Hedge Way
    Sharnbrook
    MK44 1JR Bedford
    Bedfordshire
    British114018470001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GARNER, Tony Christopher
    7 Grange Road
    MK45 4RE Barton Le Clay
    Bedfordshire
    Amministratore
    7 Grange Road
    MK45 4RE Barton Le Clay
    Bedfordshire
    EnglandBritish79630360001
    JAMES, Peter
    9 High View Road
    South Woodford
    E18 2HN London
    Amministratore
    9 High View Road
    South Woodford
    E18 2HN London
    EnglandBritish86901660001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Amministratore
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    MURPHY, John William
    19 Esplanade Gardens
    SS0 8JP Westcliff On Sea
    Essex
    Amministratore
    19 Esplanade Gardens
    SS0 8JP Westcliff On Sea
    Essex
    EnglandBritish202959810002
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    British112119110001
    FORBES NOMINEES LIMITED
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    Amministratore
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    67773780001

    RIPSHORE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a hammarsfield standon near ware. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0