VALEFROST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVALEFROST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05312146
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VALEFROST LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VALEFROST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley House
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VALEFROST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VALEFROST LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VALEFROST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    4 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Gavin Nimmo Cameron come amministratore in data 03 nov 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Michael Jowsey come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Michael Forde come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gavin Nimmo Cameron il 13 gen 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gavin Nimmo Cameron il 08 gen 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Gavin Nimmo Cameron come amministratore in data 26 gen 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Anthony Mcquade come amministratore in data 26 gen 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ashby Street 1 Bridge Street Staines TW18 4TP in data 20 dic 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di VALEFROST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    JOWSEY, Christopher Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish152505410002
    MOORE, Christopher John
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley House
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Segretario nominato
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Amministratore
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    CAMERON, Gavin Nimmo
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish87163500002
    GRUNNEL, Mark
    3 Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    Amministratore
    3 Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    United KingdomBritish107643340002
    MACINTYRE, Donald Calum
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    ScotlandBritish140968790001
    MCQUADE, Stephen Anthony
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley House
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley House
    United Kingdom
    ScotlandBritish161091550001
    SANTRY, Kevin James Albert
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    2-4
    ScotlandBritish,Irish151364260001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Amministratore
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    TCHENGUIZ, Robert
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    Amministratore
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    EnglandBritish74322720004
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Amministratore delegato nominato
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    VALEFROST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 04/08/2006 and
    Creato il 27 lug 2006
    Consegnato il 18 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All stars international 326-328 brook street broughty ferry dundee t/no ANG19917, all stars international 17-19 swan street brechin t/no ANG25146 and all stars internationas 85-87 commercial street dundee for details of further properties charged please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 18 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 06 giu 2006
    Consegnato il 22 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bedroom 127 micklegate york t/no nyk 1401971, black swan 12 new road spalding lincs t/no LL117200 and broadways 15 the broadway newbury berks t/no BK325120 for details of further properties charged please refer to form 395 all buildings fixtures fittings and fixed plat and machinery the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 22 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 22 mag 2006
    Consegnato il 02 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The townhouse 21-23 queen's road southend-on-sea t/no EX154112 and the barcode (formerly k/a the caledonian) 17 bothchergate carlisle t/no CU166351. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 02 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 24 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargors whole right title and interest in and to the rental income from the properties.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 30 january 2006 and
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the licensed premises k/a burnfoot roadhouse burnfoot hawick t/no ROX7282,all and whole the licensed premises k/a the horse & hound bonchester bridge by hawick t/no ROX7281,all and whole the licensed premises and k/a stampers 2/6 north bridge street hawick t/no ROX7280 (for details of further properties charged please refer to form 395).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 25 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or ot become due from each chargor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Albert inn 40 mount street northwood hanley stoke on trent t/no SF311537, bay wickentree lane failsworth t/no LA305120 and cock horse main street peasemarsh t/no ESX186313 for details of further properties charged please refer to form 395 all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 25 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 23 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or ot become due from each chargor to any creditor on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0