BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05312262 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DELTA RETAIL PROPERTIES LIMITED | 08 feb 2005 | 08 feb 2005 |
| PLANTLAWN LIMITED | 14 dic 2004 | 14 dic 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Stuart Macey come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Bryan Lewis come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2021 | 15 pagine | AA | ||
legacy | 238 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2020 | 17 pagine | AA | ||
legacy | 231 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 21 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Mark Webb il 04 lug 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MACEY, Paul Stuart | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205652070001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 189931090001 | |||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 70 Barrowgate Road Chiswick W4 4QU London | British | 79807180001 | ||||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| VANDEVIVERE, Jean-Marc | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | 170947050001 | |||||||||
| WEBB, Nigel Mark | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 58059360001 | |||||||||
| WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Department Stores Holding Company Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BRITISH LAND DEPARTMENT STORES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Twenty-ninth supplemental composite trust deed | Creato il 14 dic 2012 Consegnato il 21 dic 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The arding and hobbs department store the f/h land being 315-325 (odd inclusive) lavender hill 1-17 (odd inclusive) st john's road and 2-42 (even inclusive) ilminster gardens london t/no 411802 and by way of first fixed charge any other estate right title or interest in the new charged property subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 giu 2009 Consegnato il 22 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H title of the debenhams store, 315-325 (odd inclusive) lavender hill, 1-17 (odd inclusive) st john's road, and 2-42 (even inclusive) ilminster gardens, london and all covenants and rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0