EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05324341 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
- Strutture residenziali di assistenza per persone con difficoltà di apprendimento, disturbi mentali e abuso di sostanze (87200) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Voyage Care Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COMMUNITAS ACQUISITIONS LIMITED | 21 giu 2005 | 21 giu 2005 |
| COMMUNITAS HOLDINGS LIMITED | 17 giu 2005 | 17 giu 2005 |
| PIMCO 2238 LIMITED | 05 gen 2005 | 05 gen 2005 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Andre Sealey come amministratore in data 09 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Wei Roberts come amministratore in data 09 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD United Kingdom* in data 25 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Mckendrick come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Wei Roberts come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 set 2013 al 31 mar 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY* in data 13 mar 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Hayward come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Donaldson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Andre Sealey come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Winning come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Bruce Mckendrick come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEALEY, Philip Andre | Segretario | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | 176565040001 | |||||||
| SEALEY, Philip Andre | Amministratore | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire | England | British | 45325360001 | |||||
| WINNING, Andrew | Amministratore | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | 73772160002 | |||||
| ALFLATT, John Neal | Segretario | The Old Rectory St Andrew Street SG14 1HZ Hertford | British | 86320800002 | ||||||
| HYATT, Gregory John | Segretario | The Firs 27 Crookham Road GU51 5DP Fleet Hampshire | British | 61663230001 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| BURNS, Thomas | Amministratore | Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley GU15 3SY Surrey | United Kingdom | British | 78519600001 | |||||
| DONALDSON, Neil | Amministratore | Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley GU15 3SY Surrey | England | British | 172494110001 | |||||
| HAYWARD, James Duncan Henry | Amministratore | Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley GU15 3SY Surrey | England | British | 24500050002 | |||||
| HYATT, Gregory John | Amministratore | The Firs 27 Crookham Road GU51 5DP Fleet Hampshire | United Kingdom | British | 61663230001 | |||||
| LANE, Geoffrey Roy | Amministratore | Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley GU15 3SY Surrey | England | British | 20198450001 | |||||
| MCKENDRICK, James Bruce | Amministratore | 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Garrick House Staffordshire United Kingdom | England | British | 154043480001 | |||||
| PATEL, Mahesh Shivabhai | Amministratore | 29 The Avenue HA5 5BN Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 80756410001 | |||||
| ROBERTS, Kevin Wei | Amministratore | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | 72030660002 | |||||
| SAVAGE, Andrew | Amministratore | Lindisfarne The Cloisters Wadworth Hall Lane Wadworth DN11 9BH Doncaster | England | British | 117869550001 | |||||
| TURNER, Thelma Lucille | Amministratore | 5 Bar Road North Beckingham DN10 4NN Doncaster Cobblers Cottage South Yorkshire | United Kingdom | British | 170427170001 | |||||
| WHITTAKER, George Anthony David | Amministratore | Ketton House Ketton PE9 3TD Aldgate Rutland | England | British | 125108980001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 18 dic 2006 Consegnato il 29 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 lug 2005 Consegnato il 18 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A charge over shares in PS25 limited | Creato il 01 lug 2005 Consegnato il 18 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared paid or made. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A charge over sharesin opus acquisition limited | Creato il 01 lug 2005 Consegnato il 18 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared paid or made. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 01 lug 2005 Consegnato il 11 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All properties now owned by such company or in which such company has an interest,all present and future propetrties,fixed charge all equipment,all securities,all debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0