EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED

EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05324341
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza per persone con difficoltà di apprendimento, disturbi mentali e abuso di sostanze (87200) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMMUNITAS ACQUISITIONS LIMITED 21 giu 200521 giu 2005
    COMMUNITAS HOLDINGS LIMITED17 giu 200517 giu 2005
    PIMCO 2238 LIMITED05 gen 200505 gen 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Philip Andre Sealey come amministratore in data 09 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Wei Roberts come amministratore in data 09 gen 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2015

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD United Kingdom* in data 25 set 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di James Mckendrick come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kevin Wei Roberts come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 set 2013 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY* in data 13 mar 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di James Hayward come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Donaldson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Andre Sealey come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Winning come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr James Bruce Mckendrick come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    176565040001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritish45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish73772160002
    ALFLATT, John Neal
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    Segretario
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    British86320800002
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Segretario
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    British61663230001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BURNS, Thomas
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Amministratore
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    United KingdomBritish78519600001
    DONALDSON, Neil
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Amministratore
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish172494110001
    HAYWARD, James Duncan Henry
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Amministratore
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish24500050002
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    LANE, Geoffrey Roy
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Amministratore
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish20198450001
    MCKENDRICK, James Bruce
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154043480001
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish80756410001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish72030660002
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Amministratore
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    TURNER, Thelma Lucille
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    Amministratore
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170427170001
    WHITTAKER, George Anthony David
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    Amministratore
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    EnglandBritish125108980001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    EVESLEIGH ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 18 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A charge over shares in PS25 limited
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 18 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared paid or made. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A charge over sharesin opus acquisition limited
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 18 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared paid or made. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 11 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All properties now owned by such company or in which such company has an interest,all present and future propetrties,fixed charge all equipment,all securities,all debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Equity Partnership Investment Compnay PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0