HYDROKEM UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HYDROKEM UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05336838 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HYDROKEM UK LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HYDROKEM UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cavell House Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HYDROKEM UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRABCO 510 LIMITED | 19 gen 2005 | 19 gen 2005 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HYDROKEM UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per HYDROKEM UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 01 set 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2019 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2018 | 36 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione di Vincent Frederic John East come persona con controllo significativo il 05 feb 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Clinimed (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 05 feb 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vincent Frederic John East come amministratore in data 05 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Graeme Bytheway come amministratore in data 05 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sean Lea Farbrother come amministratore in data 05 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Suzanne Bryden come segretario in data 05 feb 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christine Hanlon come segretario in data 05 feb 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HYDROKEM UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYDEN, Suzanne | Segretario | Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe Cavell House England | 242845610001 | |||||||
| BYTHEWAY, David Graeme | Amministratore | Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe Cavell House England | England | British | 98874960001 | |||||
| FARBROTHER, Sean Lea | Amministratore | Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe Cavell House England | England | British | 154075270001 | |||||
| HANLON, Christine | Segretario | 83 Windermere Road CH43 9RE Prenton Merseyside | British | 104742260001 | ||||||
| BRABNERS SECRETARIES LIMITED | Segretario | C/O Brabners Chaffe Street 1 Dale Street L2 2PP Liverpool Merseyside | 79875300001 | |||||||
| EAST, Vincent Frederic John | Amministratore | 12 Polegate Wigmore Lane LU2 8AJ Luton Bedfordshire | England | British | 65407570001 | |||||
| JOHANSEN, David | Amministratore | 45 Marfords Avenue Bromborough CH63 0JJ Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 106214840001 | |||||
| BRABNERS DIRECTORS LIMITED | Amministratore | C/O Brabners Chaffe Street 1 Dale Street L2 2PP Liverpool Merseyside | 79875290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HYDROKEM UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinimed (Holdings) Limited | 05 feb 2018 | Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe Cavell House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Vincent Frederic John East | 06 apr 2016 | Knaves Beech Way Loudwater HP10 9QY High Wycombe Cavell House England | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HYDROKEM UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 20 feb 2013 Consegnato il 26 feb 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H unit 4 hickmans road, birkenhead t/n MS76266. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 nov 2011 Consegnato il 03 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as warehouse and 3 hickmans road, wallasey, t/no: MS400485 and MS350847. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 22 nov 2011 Consegnato il 30 nov 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 25 set 2006 Consegnato il 05 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Apartment 10 the old school house berryford road wirral t/no MS524664. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 giu 2005 Consegnato il 09 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 3 hichmans road west float industrial estate birkenhead t/n's MS400485 and MS350847,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture | Creato il 24 giu 2005 Consegnato il 29 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0