HYDROKEM UK LIMITED

HYDROKEM UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYDROKEM UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05336838
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYDROKEM UK LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HYDROKEM UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cavell House Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYDROKEM UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRABCO 510 LIMITED19 gen 200519 gen 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYDROKEM UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HYDROKEM UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Stato del capitale al 01 set 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2019 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2018

    36 pagineAA

    Cessazione di Vincent Frederic John East come persona con controllo significativo il 05 feb 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Clinimed (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 05 feb 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Vincent Frederic John East come amministratore in data 05 feb 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Graeme Bytheway come amministratore in data 05 feb 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Sean Lea Farbrother come amministratore in data 05 feb 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Suzanne Bryden come segretario in data 05 feb 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christine Hanlon come segretario in data 05 feb 2018

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di HYDROKEM UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRYDEN, Suzanne
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    Segretario
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    242845610001
    BYTHEWAY, David Graeme
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    Amministratore
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    EnglandBritish98874960001
    FARBROTHER, Sean Lea
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    Amministratore
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    EnglandBritish154075270001
    HANLON, Christine
    83 Windermere Road
    CH43 9RE Prenton
    Merseyside
    Segretario
    83 Windermere Road
    CH43 9RE Prenton
    Merseyside
    British104742260001
    BRABNERS SECRETARIES LIMITED
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79875300001
    EAST, Vincent Frederic John
    12 Polegate
    Wigmore Lane
    LU2 8AJ Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Polegate
    Wigmore Lane
    LU2 8AJ Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritish65407570001
    JOHANSEN, David
    45 Marfords Avenue
    Bromborough
    CH63 0JJ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    45 Marfords Avenue
    Bromborough
    CH63 0JJ Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish106214840001
    BRABNERS DIRECTORS LIMITED
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79875290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HYDROKEM UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Clinimed (Holdings) Limited
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    05 feb 2018
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England
    Numero di registrazione02640337
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Vincent Frederic John East
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    06 apr 2016
    Knaves Beech Way
    Loudwater
    HP10 9QY High Wycombe
    Cavell House
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HYDROKEM UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2013
    Consegnato il 26 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 4 hickmans road, birkenhead t/n MS76266.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2011
    Consegnato il 03 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as warehouse and 3 hickmans road, wallasey, t/no: MS400485 and MS350847.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 ott 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 25 set 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Apartment 10 the old school house berryford road wirral t/no MS524664. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    3 hichmans road west float industrial estate birkenhead t/n's MS400485 and MS350847,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael George Squire and Francis Thomas Thompson in Their Capacity as Security Trustee for Thesecured Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 24 giu 2005
    Consegnato il 29 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0