INHOCO 4085 LIMITED

INHOCO 4085 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINHOCO 4085 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05337036
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INHOCO 4085 LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INHOCO 4085 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di INHOCO 4085 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INHOCO 4085 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per INHOCO 4085 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Senior facilities agreement 15/02/2016
    RES13

    Iscrizione dell'ipoteca 053370360007, creata il 17 feb 2016

    27 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2016

    Stato del capitale al 16 feb 2016

    • Capitale: GBP 100,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Temple-Heald il 31 gen 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Douglas John Graham il 31 gen 2016

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Douglas John Graham il 31 gen 2016

    2 pagineCH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2015

    • Capitale: GBP 100,002
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    12 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 053370360006, creata il 17 mar 2015

    67 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 053370360005 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    11 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 053370360005, creata il 19 set 2014

    37 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di INHOCO 4085 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAHAM, Douglas John
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    Segretario
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    BritishDirector131559520001
    GRAHAM, Douglas John
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    Amministratore
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director131559520001
    TEMPLE-HEALD, Nicholas
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    Amministratore
    Birmingham Road
    Allesley
    CV5 9AB Coventry
    Landscapes House 3 Rye Hill Office Pk
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector74074550002
    COPP, Christine Marie
    Shaw Cottage
    Ashampstead
    RG8 8RG Reading
    Berkshire
    Segretario
    Shaw Cottage
    Ashampstead
    RG8 8RG Reading
    Berkshire
    BritishGroup Accountant116623380001
    GOLDSTEIN, Robert Frank
    10 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    10 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Hertfordshire
    BritishCo Director38793910004
    SAVILLE, Paul
    4 Compton Crescent
    Chiswick
    W4 3JA London
    Segretario
    4 Compton Crescent
    Chiswick
    W4 3JA London
    BritishAccountant57981540001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ALEXANDER, Harvey Louis
    Beechburn
    Southview Road
    HA5 3XZ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Beechburn
    Southview Road
    HA5 3XZ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director49803880001
    ALEXANDER, Mark Samson
    Fox End
    Nugents Park
    HA5 5RA Hatch End
    Middlesex
    Amministratore
    Fox End
    Nugents Park
    HA5 5RA Hatch End
    Middlesex
    BritishCompany Director41650170004
    GOLDSTEIN, Robert Frank
    10 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishCo Director38793910004
    HOLLAND, Peter John
    77 Frome Road
    BA14 0DW Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    77 Frome Road
    BA14 0DW Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector94946420001
    HUNT, Martin Robert
    67 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    67 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector104609440001
    OLIVER, Mark James
    Long Street
    Easingwold
    YO61 3JA York
    Green Tree House 160
    North Yorkshire
    Amministratore
    Long Street
    Easingwold
    YO61 3JA York
    Green Tree House 160
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector129433110001
    SAVILLE, Paul
    4 Compton Crescent
    Chiswick
    W4 3JA London
    Amministratore
    4 Compton Crescent
    Chiswick
    W4 3JA London
    EnglandBritishAccountant57981540001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    INHOCO 4085 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 feb 2016
    Consegnato il 24 feb 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc France
    Transazioni
    • 24 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 mar 2015
    Consegnato il 23 mar 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc France (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 19 set 2014
    Consegnato il 30 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 03 mar 2010
    Consegnato il 10 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 31ST march 2008 and
    Creato il 05 set 2008
    Consegnato il 10 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 04 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0