MORSTON HICKLING LIMITED

MORSTON HICKLING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORSTON HICKLING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05337651
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORSTON HICKLING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MORSTON HICKLING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7th Floor 9 Berkeley Street
    W1J 8DW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORSTON HICKLING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MORSTON HICKLING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 07 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2016

    Stato del capitale al 18 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AL a 7th Floor 9 Berkeley Street London W1J 8DW in data 07 lug 2016

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 mag 2015

    17 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2015

    Stato del capitale al 06 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 mag 2014

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio modificato redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAAMD

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor 22 Grafton Street London W1S 4EX United Kingdom* in data 23 gen 2014

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sixth Floor 63 Curzon Street London W1J 8PD* in data 21 nov 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Anthony Underwood-Whitney come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Le Quesne come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Saffron Harrop come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roberto Monticelli come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Miranda Lansdowne come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Burgin come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Castle Directors Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Nomina di Jtc Directors Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Dettagli del segretario cambiati per Jtc Management Limited il 21 mag 2012

    3 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di MORSTON HICKLING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JTC JERSEY LIMITED
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Isles
    Segretario
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Isles
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione37293
    160252880002
    CUDLIPP, Martin Gordon
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    JerseyBritish172570330001
    CASTLE DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione102673
    170374650001
    JTC DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione100165
    170374460001
    ELLIS, Linda Denise
    2 Lansdowne Road
    Union Park, Fifers Lane
    NR6 6NF Norwich
    Norfolk
    Segretario
    2 Lansdowne Road
    Union Park, Fifers Lane
    NR6 6NF Norwich
    Norfolk
    Other93926710001
    ROBSON, Malcolm Henry
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    Segretario
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    British6205710001
    AIBJERSEYTRUST LIMITED
    25 Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    Aib House
    Segretario
    25 Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    Aib House
    85248580007
    BARRETT, Linda Jane
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    Amministratore
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    British135027860001
    BAUDAINS, James Kenneth
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    British136150950001
    BIZLEY, Stuart Michael
    16 Chestnut Road
    Scarning
    NR19 2TA Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    16 Chestnut Road
    Scarning
    NR19 2TA Dereham
    Norfolk
    EnglandBritish93403500001
    BLAMPIED, Michael Norman
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    Amministratore
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    UkBritish150439570001
    BURGIN, Philip Henry
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyEnglish120326900007
    CROWE, Anthony Charles
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    Amministratore
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    British135028380001
    FRY, Chrispian Francis Anstee
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    Amministratore
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    JerseyBritish191605130001
    GORROD, Joanne Louise
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Amministratore
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Jersey, Channel IslandsBritish175845830001
    HARRISON, Thomas Frederick Teviot
    Hall Farm
    NR25 7AA Morston
    Norfolk
    Amministratore
    Hall Farm
    NR25 7AA Morston
    Norfolk
    United KingdomBritish81581440001
    HARROP, Saffron Louise
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish,120408490001
    LANSDOWNE, Miranda Suzanne Helen
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Jersey Channel IslandsBritish160253960001
    LE COUILLIARD, David Philip
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Jersey Channel IslesBritish135028580001
    LE QUESNE, Nigel Anthony
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish71675010004
    MONTICELLI, Roberto
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish148791260001
    MONTICELLI, Roberto
    7 Orchard Mews
    Tower Road, St Helier
    JE2 3LX Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    7 Orchard Mews
    Tower Road, St Helier
    JE2 3LX Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritish148791260001
    NORTON, Nicholas George
    2 Lansdowne Road
    Union Park, Fifers Lane
    NR6 6NF Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    2 Lansdowne Road
    Union Park, Fifers Lane
    NR6 6NF Norwich
    Norfolk
    Other97713370001
    ROBSON, Malcolm Henry
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    65 Bury Street
    NR2 2DL Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish6205710001
    STAPLES, Anthony John
    Adison, Le Jardin De Lest
    La Rue De La Rosiere St. Mary
    JE3 3DG Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Adison, Le Jardin De Lest
    La Rue De La Rosiere St. Mary
    JE3 3DG Jersey
    Channel Islands
    British73941150001
    UNDERWOOD-WHITNEY, Anthony James
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish160254210001
    WHEELER, Lorraine Fay
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Channel IslandsBritish100921140001
    AIBJT CORPORATE LIMITED
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    Amministratore
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    92635870003
    AIBWT CORPORATE LIMITED
    Aib House PO BOX 361
    Grenville Street
    JE4 9WN St Helier
    Jersey
    Amministratore
    Aib House PO BOX 361
    Grenville Street
    JE4 9WN St Helier
    Jersey
    92635870001

    MORSTON HICKLING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 14 dic 2005
    Consegnato il 22 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3663 birmingham depot kingswood lakeside cannock t/no SF504631. Assigned its interest in any licences and in the rental income. By way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools any investment goodwill and uncalled capital and any intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks, P.L.C. in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 22 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 04 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land at norton lane, leacroft. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 04 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0