RED-M GROUP LIMITED

RED-M GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRED-M GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05360892
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RED-M GROUP LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova RED-M GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Graylands Langhurstwood Road
    Warnham
    RH12 4QD Horsham
    West Sussexx
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RED-M GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3720) LIMITED10 feb 200510 feb 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di RED-M GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per RED-M GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2010

    Stato del capitale al 17 feb 2010

    • Capitale: GBP 513,794.38
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen George Geddes il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Neil James Clark il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    21 pagineAA

    legacy

    15 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Interested directors 10/12/2008
    RES13

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2007

    28 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    57 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    legacy

    1 pagine123

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    14 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2006

    28 pagineAA

    legacy

    10 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di RED-M GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Neil James
    2 Mullein Road
    OX26 3WE Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    2 Mullein Road
    OX26 3WE Bicester
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant205333860001
    CLARK, Neil James
    Graylands Langhurstwood Road
    Warnham
    RH12 4QD Horsham
    West Sussexx
    Amministratore
    Graylands Langhurstwood Road
    Warnham
    RH12 4QD Horsham
    West Sussexx
    EnglandBritishAccountant205333860001
    CRAIG, Paul
    17 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    17 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Engineer93751680002
    ELDER, Andrew Murdoch
    Flat 1
    88 Tachbrook Street
    SW1V 2NB London
    Amministratore
    Flat 1
    88 Tachbrook Street
    SW1V 2NB London
    United KingdomBritishVenture Capital114249970001
    GEDDES, Stephen George
    7 Queens Mansions
    Brook Green
    W6 7EB London
    Amministratore
    7 Queens Mansions
    Brook Green
    W6 7EB London
    United KingdomBritishInvestment Manager40156590003
    GRECO, Richard Anthony
    12 Hartford Street
    W1J 7RW London
    Amministratore
    12 Hartford Street
    W1J 7RW London
    United StatesAmericanCeo105765470001
    JENSON, Lisa
    17 Goodwood Close
    PO8 8BG Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    17 Goodwood Close
    PO8 8BG Portsmouth
    Hampshire
    British105368860001
    KILCOYNE, Rosemary
    April Dene
    Hervines Road
    HP6 5HS Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    April Dene
    Hervines Road
    HP6 5HS Amersham
    Buckinghamshire
    Irish106237650001
    POULTON, Simon Nicholas
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British11323860002
    RICHMOND, David Jeremy Norcross
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    Segretario
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    British31352060001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    ASHWORTH, Gordon Neville
    Northampton Square
    EC1V 0AJ London
    19
    Amministratore
    Northampton Square
    EC1V 0AJ London
    19
    EnglandBritishAccountant62591920003
    BRISTOW, Geoffrey John, Dr
    Panniers Farm Castle Lane
    Wookey
    BA5 1NL Wells
    Somerset
    Amministratore
    Panniers Farm Castle Lane
    Wookey
    BA5 1NL Wells
    Somerset
    BritishConsultant35929320004
    FEILDER, Karl William
    12 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    12 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector100523650001
    HEALEY, Russell George
    34a Greenland Road
    NW1 0AY London
    Amministratore
    34a Greenland Road
    NW1 0AY London
    United KingdomBritishVenture Capitalist114711780001
    JEYNES, Roger David
    7 Tekels Avenue
    GU15 2LA Camberley
    Surrey
    Amministratore
    7 Tekels Avenue
    GU15 2LA Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector54514460001
    MCTIGHE, Robert Michael
    Danesbury House
    4 Waverley Grove
    B91 1NP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Danesbury House
    4 Waverley Grove
    B91 1NP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector70913450003
    NAHAMA, David Louis
    43-45 Blenheim Crescent
    Flat 6
    W11 2EF London
    Amministratore
    43-45 Blenheim Crescent
    Flat 6
    W11 2EF London
    United KingdomAmericanVenture Capitalist141913580001
    POULTON, Simon Nicholas
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector11323860002
    RICHMOND, David Jeremy Norcross
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector31352060001
    RISMAN, Michael Adam
    Flat 3
    47 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Amministratore
    Flat 3
    47 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritishVenture Capitalist141485810001
    RISMAN, Michael Adam
    Flat 3
    47 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Amministratore
    Flat 3
    47 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritishVenture Capitalist141485810001
    SAUNDERS, Simon Reza
    Maryland
    Browns Lane
    RH20 4LQ Storrington
    West Sussex
    Amministratore
    Maryland
    Browns Lane
    RH20 4LQ Storrington
    West Sussex
    EnglandBritishDirector238104070001
    SKINNER, Peter Jackson
    Eakley Manor Farm
    Stoke Goldington
    MK16 8LP Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Eakley Manor Farm
    Stoke Goldington
    MK16 8LP Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishVenture Capitalist81440880001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    RED-M GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 lug 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the 2008 noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Private Investor Capital Limited (Acting as Security Agent)(the Security Agent)
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 16 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the holders of loan notes (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Private Investor Capital Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • D. B. Zwirn Luxembourg Sarl.
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apax Partners Europe Managers Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Interregnum PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apax Partners Europe Managers Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0