BROMSGROVE STREET LIMITED

BROMSGROVE STREET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBROMSGROVE STREET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05365574
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BROMSGROVE STREET LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BROMSGROVE STREET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BROMSGROVE STREET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BROMSGROVE STREET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR United Kingdom in data 04 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 set 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2012

    Stato del capitale al 14 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Colin Richard Clapham come segretario in data 12 gen 2012

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Karen Lorraine Atterbury come segretario in data 12 gen 2012

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Simon James Brown il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ingrid Ruth Skinner il 22 lug 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Andrew Reid il 01 set 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Andrew Reid il 21 lug 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 80 New Bond Street London W1S 1SB in data 05 apr 2011

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Karen Lorraine Atterbury il 28 mar 2011

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ingrid Ruth Gelley il 12 ott 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vahid Alaghband il 27 lug 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BROMSGROVE STREET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    166216640001
    ALAGHBAND, Nader
    31-32 Kensington Park Gardens
    W11 2QS London
    Flat 6
    Amministratore
    31-32 Kensington Park Gardens
    W11 2QS London
    Flat 6
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British120915300001
    ALAGHBAND, Vahid
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish5674390001
    BROWN, Simon James
    101-135
    Kings Road
    CM14 4DR Brentwood
    Kings House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    101-135
    Kings Road
    CM14 4DR Brentwood
    Kings House
    Essex
    United Kingdom
    BritainBritish46898530007
    REID, David Andrew
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritish155269870001
    SKINNER, Ingrid Ruth
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritish133605100002
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British175715660001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Other135442010007
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Segretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Segretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Segretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Segretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    CML SECRETARIES LIMITED
    2 Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    West Sussex
    Segretario
    2 Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    West Sussex
    74740960001
    ATKIN, Peter Neil
    Hurst Dene
    New Place
    RH20 1AT Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Hurst Dene
    New Place
    RH20 1AT Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish10294000001
    COOK, Richard John
    23 Hawthorne Drive
    School Aycliffe
    DL5 6GH Darlington
    County Durham
    Amministratore
    23 Hawthorne Drive
    School Aycliffe
    DL5 6GH Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish178588500001
    DODDS, Graeme James
    16 Second Avenue
    CO13 9ER Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    16 Second Avenue
    CO13 9ER Frinton On Sea
    Essex
    EnglandBritish146495490001
    FREEMAN, Emma Louise
    13 Beverley Path
    Barnes
    SW13 0AL London
    Amministratore
    13 Beverley Path
    Barnes
    SW13 0AL London
    British113500840001
    HAYS, Richard William
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    Amministratore
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    United KingdomBritish90336020002
    HAYS, Richard William
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    Amministratore
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    United KingdomBritish90336020002
    MARTIN, Roderick Adrian
    30 Juniper Close
    RH8 0RX Oxted
    Surrey
    Amministratore
    30 Juniper Close
    RH8 0RX Oxted
    Surrey
    British105672190002
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Amministratore
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritish75750250002
    SOUTHCOMBE, Michael Arthur
    5 Mackie Avenue
    BN6 8NH Hassocks
    West Sussex
    Amministratore
    5 Mackie Avenue
    BN6 8NH Hassocks
    West Sussex
    United KingdomBritish33313590001
    TILLOTSON, David Gregory
    Stubbards Croft
    Vine Street
    CM7 4SR Great Bardfield
    Essex
    Amministratore
    Stubbards Croft
    Vine Street
    CM7 4SR Great Bardfield
    Essex
    United KingdomBritish118374930001
    TURNER, Niki Jayne
    76 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    Amministratore
    76 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    British99481440001
    WOOLSEY, Richard John
    33 Victoria Wharf 46 Narrow Street
    E14 8DD London
    Amministratore
    33 Victoria Wharf 46 Narrow Street
    E14 8DD London
    EnglandBritish111162100001

    BROMSGROVE STREET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 27 set 2007
    Consegnato il 03 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its entire right title and interest in and to the contract. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 06 set 2007
    Consegnato il 07 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its entire right title and interest in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 18 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings at hurst street bromsgrove street pershore street and claybrook street birmingham t/n WM857697. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 18 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    BROMSGROVE STREET LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mar 2013Data di scioglimento
    18 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0