LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED

LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOYDS PROPCO NO.1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05372227
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thornton Uk Llp 30
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NHP PROPCO LIMITED11 apr 200511 apr 2005
    CLEARPLACE LIMITED22 feb 200522 feb 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 18 apr 2016

    21 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mar 2016

    41 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 set 2015

    30 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mar 2015

    30 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 set 2014

    30 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mar 2014

    29 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 apr 2013

    26 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 05 mar 2013

    35 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mar 2012

    27 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 set 2011

    31 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 North End Road London NW11 7RJ* in data 20 ott 2011

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011

    3 pagineAA01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 apr 2011

    27 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    legacy

    1 pagineLQ02

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 ott 2010

    27 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CASARI, Tracey
    Rainstrasse
    CH-8955 Oetwil An Der Limmat
    29
    Zurich
    Switzerland
    Amministratore
    Rainstrasse
    CH-8955 Oetwil An Der Limmat
    29
    Zurich
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292310001
    DEN HOLLANDER, Patricia
    Wilby Road 2-17
    Lobby 9
    276306 The Tessarina
    22
    Amministratore
    Wilby Road 2-17
    Lobby 9
    276306 The Tessarina
    22
    SingaporeIrish146292430001
    MUNTWYLER, Jean-Claude
    Steinhaldenstrasse
    CH-8002 Zurich
    63
    Switzerland
    Amministratore
    Steinhaldenstrasse
    CH-8002 Zurich
    63
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292590001
    RECHSTEINER, Laurianne Karin
    Schlierenstrasse
    CH-8142 Uitikon/Waldegg
    50
    Switzerland
    Amministratore
    Schlierenstrasse
    CH-8142 Uitikon/Waldegg
    50
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss146292610001
    DEUTSCH, Chaim
    296 Golders Green Road
    NW11 9YP London
    Segretario
    296 Golders Green Road
    NW11 9YP London
    British108073640001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DEUTSCH, Chaim Leib
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    Amministratore
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    EnglandBritish61133060001
    GURVITZ, Joseph
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Amministratore
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    United KingdomBritish90042110003
    GURVITZ, Meir
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Amministratore
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    EnglandBritish43943590002
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Amministratore
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Amministratore delegato nominato
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    VECHT, Dina
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    Amministratore
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    United KingdomBritish127487970001

    LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental legal charge
    Creato il 19 nov 2008
    Consegnato il 27 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the acquired property being land forming part of wellesley house, botham hall road, huddersfield and all buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 15 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Abbeygate residential home 42 quarry road st giles road winchester hampshire t/no HP289568 addison court addison street accrington lancs t/no LA774444 and LA589003 alexandra nursing home 46 alexandra road hemel hempstead hertfordshire t/no HD368759. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 15 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 211 feb 2010Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 202 mar 2011Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 2
    Mortgage and charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 12 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that the lands and premisies situate at and k/a ardmaine nursing home, fullerton road, newry, county down folio number DN134573; all that the lands and premisessituate at and k/a chestnut lodge nursing home, 47 carrickaness road, benburb, county tyrone and comprised in folio 15505; all that the lands and premises situate at and k/a rosemary lodge/orchard manor nursing homes, 7/9 fennel road, antrim, county antrim, partly comprised in folio AN20843L (for details of further properties charged please refer to form 395) by way of first fixed charge the benefit of all agreements, all shares, rights, benefits and advantages and by way of floating charge all plant, machinery and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 05 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Alexandra nursing home 46 alexandra road hemel hempstead herts, the rookery queens sq ebbw vale gwent and oak tree house (f/k/a goose green) gravel hill goose green yate bristol avon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 05 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H churchfield nursing home churchfield drive rainworth mansfield notts t/nos NT304587 and NT333201. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage/charge
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Chestnut lodge nursing home 47 carrickaness road benburb county tyrone folio/n 15505, rosevale nursing home 173 moira road lisburn county antrim folio/n AM38208, rosemary lodge/orchard manor nursing homes 7-9 fennel road antrim county antrim folio/n AN20843L all f/h unregistered land, all l/h unregistered land, all registered land. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LOYDS PROPCO NO.1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert John Belcher
    St. Catherines Court Berkeley Place
    BS8 1BQ Bristol
    Avon
    Ricevitore/gestore
    St. Catherines Court Berkeley Place
    BS8 1BQ Bristol
    Avon
    David John Newall
    81 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    Ricevitore/gestore
    81 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    3
    DataTipo
    19 apr 2010Inizio dell'amministrazione
    18 apr 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Robert Harry Pick
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0