CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED

CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05394498
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3734) LIMITED16 mar 200516 mar 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al27 gen 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma10 feb 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al27 gen 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Steven Michael Ryland come amministratore in data 12 lug 2019

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 gen 2019

    LRESSP

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 18 set 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Thomas Peter Alcock come segretario in data 15 feb 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Kirsty Jane Bingham come segretario in data 15 feb 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Caldicott Williams il 01 lug 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Brad Scott Huntington il 11 gen 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mrs Kirsty Jane Bingham come segretario in data 11 gen 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Alistair Myrie Holl come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Doreen Pauline Elizabeth Richards come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Steven Michael Ryland come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Caldicott Williams come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Brad Scott Huntington come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tess Bridgman come segretario in data 11 gen 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Robert Pike come amministratore in data 11 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 11 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 11 gen 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a 20 Old Broad Street London EC2N 1DP in data 26 gen 2017

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALCOCK, Thomas Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    244686860001
    HUNTINGTON, Brad Scott
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    BermudaCanadianInsurance Professional182734090005
    RICHARDS, Doreen Pauline Elizabeth
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    BermudaBritishAccountant147833420001
    WILLIAMS, John Caldicott
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    BermudaBritishInsurance Professional169106330013
    BINGHAM, Kirsty Jane
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    223324200001
    BRIDGMAN, Tess
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    207851350001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189270820001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176232640001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198141780001
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    14 Eversfield Road
    RH2 0PJ Reigate
    Surrey
    Segretario
    14 Eversfield Road
    RH2 0PJ Reigate
    Surrey
    BritishDirector92108930001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishCompany Director138719750001
    HOLL, Alistair Myrie
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    WalesBritishManaging Director138014840001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    United KingdomBritishFinance Director140753960001
    PIKE, Andrew Robert
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    United KingdomBritishCompany Director155038540001
    POLLARD, Charles Nicholas
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    EnglandBritishDirector192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishDirector556710002
    RYLAND, Steven Michael
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    EnglandBritishInsurance Professional147833410001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishChief Executive Officer57775660003
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishDirector92108930002
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cory Environmental Finance Limited
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    11 gen 2017
    Old Broad Street
    EC2N 1DP London
    20
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies
    Numero di registrazione05360861
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2015
    Consegnato il 27 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental common debenture
    Creato il 29 nov 2011
    Consegnato il 08 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 18 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CORY ENVIRONMENTAL ACQUISITIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0