ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05396394 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SPEED 9983 LIMITED | 17 mar 2005 | 17 mar 2005 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 206 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 26 mar 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 27 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 27 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 27 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 27 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 27 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 27 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucinda Margaret Bell come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Mark Webb il 06 apr 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 189956910001 | |||||||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MADDISON, John Roman Patrick | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 159016320001 | |||||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 189931090001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| VANDEVIVERE, Jean-Marc | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | 170947050001 | |||||||||
| WEBB, Nigel Mark | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 58059360001 | |||||||||
| WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 | |||||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 | |||||||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 17 mar 2017 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ST JAMES RETAIL PARK NORTHAMPTON LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Third composite supplemental trust deed | Creato il 01 gen 2007 Consegnato il 10 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the principal of, and interest on all the debentures | |
Brevi particolari St james retail park southern relief road northampton t/no nn 104790 togther with all fixtures and fittings and plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental composite trust deed | Creato il 20 dic 2006 Consegnato il 03 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the f/h or l/h property at st james retail park southern relief road northampton t/n NN104790 and by way of first fixed charge any other estate right title or interest in any such other f/h or l/h properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite supplemental trust deed | Creato il 29 ago 2006 Acquisito il 01 gen 2007 Consegnato il 24 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari St james retail park southern relief road northampton t/no NN104790. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Sixteenth supplemental trust deed | Creato il 11 lug 2005 Consegnato il 28 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the rights,title and interest in the f/h premises k/a st james retail park southern releif road northampton t/no NN104790. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 06 ott 1995 Acquisito il 11 lug 2005 Consegnato il 28 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights,title and interest in the f/h premise k/a st james retail park southern releif road northampton t/no NN104790. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0