ICA MANAGED PRINT LIMITED

ICA MANAGED PRINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàICA MANAGED PRINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05407869
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    • Riparazione di altre apparecchiature (33190) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICA DIGITAL LTD30 mar 200530 mar 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 054078690007 in pieno

    1 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 054078690007, creata il 22 feb 2018

    29 pagineMR01

    Nomina di Mr David Campbell come amministratore in data 22 feb 2018

    2 pagineAP01

    legacy

    9 pagineRP04CS01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2016

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2015

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2014

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2013

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2011

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2010

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 30 mar 2012

    23 pagineRP04AR01

    Cessazione della carica di Simon Whapshott come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mark Garius come amministratore in data 22 feb 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Woodbridge House, Chapel Road, Smallfield, Surrey, RH6 9NW a 20 Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8SQ in data 23 feb 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Bryan Lloyd Taylor come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Mark Wardle come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Whapshott come segretario in data 22 feb 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di James Alan Browne come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bryan Lloyd Taylor come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert John Price come amministratore in data 22 feb 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMPBELL, David
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Amministratore
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    United KingdomBritishDirector177927020001
    GARIUS, Mark
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Amministratore
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    United KingdomSwiss,BritishDirector67448210001
    DWYER, Daniel John
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    Segretario
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    British112335920001
    FRASER, Rita
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    Segretario
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    BritishDirector70582880001
    WHAPSHOTT, Simon
    c/o C/O Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Segretario
    c/o C/O Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    BritishDirector104631160002
    BROWNE, James Alan
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Amministratore
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishSales Director221298930001
    DWYER, Daniel James
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    Amministratore
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Registration Agent86094440001
    FITZGERALD, Michael James
    2 Redwood Mount
    Beech Road
    RH2 9NB Reigate
    Surrey
    Amministratore
    2 Redwood Mount
    Beech Road
    RH2 9NB Reigate
    Surrey
    BritishCo Director37173650002
    FRASER, Rita
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    Amministratore
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    BritishDirector70582880001
    HALLISSEY, Steven Peter
    Chequers Avenue
    HP11 1GD High Wycombe
    24
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Chequers Avenue
    HP11 1GD High Wycombe
    24
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishExecutive Chairman189881910001
    HEALY, Russell
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    EnglandBritishDirector194872660001
    NASH, Andrew John
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    EnglandBritishDirector53544690001
    O'CONNOR, Mark Philip
    57 North Worple Way
    Mortlake
    SW14 8PS London
    Amministratore
    57 North Worple Way
    Mortlake
    SW14 8PS London
    United KingdomIrishCommercial Director110228770001
    POWAR, Sonita Jatinder Kaur
    Worlds End Lane
    BR6 6AT Chelsfield
    201
    Kent
    Amministratore
    Worlds End Lane
    BR6 6AT Chelsfield
    201
    Kent
    UkBritishVenture Capitalist136721480001
    PRICE, Robert John
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Amministratore
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishCommercial Director104631180002
    RAWSON, Kevin Andrew
    Southwood
    Waller Lane
    CR3 5EA Caterham
    Surrey
    Amministratore
    Southwood
    Waller Lane
    CR3 5EA Caterham
    Surrey
    United KingdomBritishCo Director37173660003
    SHANNON, Andrew James Mciver
    Woodbridge House
    Chapel Road
    RH6 9NW Smallfield
    Surrey
    Amministratore
    Woodbridge House
    Chapel Road
    RH6 9NW Smallfield
    Surrey
    EnglandBritishInvestment Management162601010001
    TAYLOR, Bryan Lloyd
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Amministratore
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishNon-Executive Chairman71356520003
    WARDLE, Christopher Mark
    Foresight Group
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Amministratore
    Foresight Group
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    EnglandBritishInvestment Director229534990001
    WHAPSHOTT, Simon
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Amministratore
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishCompany Director104631160003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ICA MANAGED PRINT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    Surrey
    England
    14 mar 2017
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06766039
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ICA MANAGED PRINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 feb 2018
    Consegnato il 01 mar 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of fixed charge all right, title, estate and other interests of the company in all freehold or leasehold property now or at any time vested in or held by or on behalf of the company and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings, erections, fixtures and fittings.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 05 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Price
    Transazioni
    • 05 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 05 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rita Fraser
    Transazioni
    • 05 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 28 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal and/or the company to the chargee and/or any of the other investors on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Foresight 2 Vct PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 28 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 25 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 03 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Toshiba Tec UK Imaging Systems Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0