HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED

HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05420734
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PLANEBELL LIMITED11 apr 200511 apr 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 mag 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 mag 2018

    9 pagineLIQ03
    A7CXLT8B

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13
    A7CXLGU2

    Indirizzo della sede legale modificato da 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ a 1 More London Place London SE1 2AF in data 17 lug 2017

    2 pagineAD01
    A6A0Z24P

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A6A0Z24X

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01
    A6A0Z25L

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 mag 2017

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 054207340007 in pieno

    4 pagineMR04
    A683RWIO

    Soddisfazione dell'onere 054207340008 in pieno

    4 pagineMR04
    A683RWIG

    Soddisfazione dell'onere 054207340009 in pieno

    4 pagineMR04
    A683RWI8

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X66P6F4P

    Bilancio redatto al 28 mag 2016

    18 pagineAA
    A5L24VZF

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 apr 2016

    Stato del capitale al 11 apr 2016

    • Capitale: GBP 9
    SH01
    X54O92HK

    Bilancio redatto al 30 mag 2015

    17 pagineAA
    A4LQFM0P

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2015

    Stato del capitale al 24 apr 2015

    • Capitale: GBP 9
    SH01
    X461802Q

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    17 pagineAA
    A3LDU6SA

    Iscrizione dell'ipoteca 054207340009

    83 pagineMR01
    A3ILONKJ

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2014

    Stato del capitale al 14 apr 2014

    • Capitale: GBP 9
    SH01
    X35RK9NV

    Cessazione della carica di Jonathan David Paveley come amministratore in data 31 gen 2014

    2 pagineTM01
    L30QQHUY

    Bilancio redatto al 01 giu 2013

    14 pagineAA
    A2L2MFWI

    Memorandum e Statuto

    13 pagineMEM/ARTS
    R2CZ3TU2

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Financing arrangements 26/06/2013
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 054207340008

    54 pagineMR01
    A2CFUO5D

    Iscrizione dell'ipoteca 054207340007

    86 pagineMR01
    A2C81CEG

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    X2636Y0J

    Chi sono gli amministratori di HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Amministratore
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    AmericanDirector98928830001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Amministratore
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Amministratore
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishCompany Director54137480002
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishCompany Diorector100582600002
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector2541420006
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Amministratore
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishDirector102593650002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5465262
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2014
    Consegnato il 16 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 12 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 12 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 09 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2009
    Consegnato il 07 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 04 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 02 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 ago 2005
    Consegnato il 13 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 13 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARMONY ACQUISITION COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 mag 2017Inizio della liquidazione
    03 dic 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0