UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Panoramica
Nome della società | UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05421321 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Indirizzo della sede legale | The Hamlet Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PBS MANAGEMENT SERVICES LTD | 11 apr 2005 | 11 apr 2005 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul John Jewell come amministratore in data 20 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Miles Skingle come amministratore in data 20 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 giu 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Miss Elizabeth Anne Brophy come segretario in data 01 giu 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy John Smyth come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy John Smyth come amministratore in data 12 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road Leeds West Yorkshire LS10 1RJ a The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE in data 12 apr 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Clive Adam Nathan come amministratore in data 06 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Paul John Jewell come amministratore in data 01 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Clive Adam Nathan come amministratore in data 01 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Maria Louise Leighton come amministratore in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian James Barclay come amministratore in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Maria Louise Leighton come amministratore in data 01 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ian James Barclay come amministratore in data 01 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROPHY, Elizabeth Anne | Segretario | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | 247171490001 | |||||||
SKINGLE, Richard Miles | Amministratore | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | Finance Director | 203052180001 | ||||
SMYTH, Timothy John | Amministratore | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | Director | 77794000006 | ||||
BLOTT, Stephen | Segretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | Company Secretary | 139352410001 | |||||
FULLERTON, Penelope Jane | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184077790001 | |||||||
MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Segretario | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | Director | 75598460002 | |||||
ORTON, Jeffrey Christopher | Segretario | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | 185572230001 | |||||||
ZACZKIEWICZ, Stacey | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170325430001 | |||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED | Segretario | 10 King William Street EC4N 7TW London | 107712310001 | |||||||
THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Corn Exchange Baffins Lane PO19 1GE Chichester West Sussex | 37896530011 | |||||||
BARCLAY, Ian James | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | Company Director | 184779440002 | ||||
BEALES, Karen Anne | Amministratore | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | Director | 135540180002 | ||||
BRADBURY, Susan Patricia | Amministratore | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 40471660002 | ||||
DAVEY, Jonathan Mark | Amministratore | 6 Mill Close Lane Patrick Brompton DL8 1AJ Bedale North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 81484820003 | ||||
GILL, Ryan Mark | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 184068890001 | ||||
HUBBARD, Peter John | Amministratore | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | Executive Consultant | 28375870003 | ||||
JEWELL, Paul John | Amministratore | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | Company Director | 221544490001 | ||||
LAIRD, Oliver Walter | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 233726140001 | ||||
LEIGHTON, Maria Louise | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | Company Director | 202291580001 | ||||
MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Amministratore | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | England | British | Director | 75598460002 | ||||
NATHAN, Clive Adam | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 207013760001 | ||||
POSNER, Howard Michael | Amministratore | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | Chairman | 139631580001 | ||||
ROLFE, Timothy Paul | Amministratore | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | Company Director | 107872640001 | ||||
SAGGU, Ranvir Singh | Amministratore | 21 Kearton Close CR8 5EN Kenley Surrey | England | British | Chartered Accountant | 115958310001 | ||||
WARREN, Michael Ian | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | Chief Operating Officer | 140310390001 | ||||
EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Lancashire | 60471930010 |
Chi sono le persone con controllo significativo di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pbsh Holdings Limited | 06 apr 2016 | Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 13 nov 2007 Consegnato il 23 nov 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £81,907.00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 gen 2007 Consegnato il 15 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 gen 2006 Consegnato il 02 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0