UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD

UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05421321
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    The Hamlet
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PBS MANAGEMENT SERVICES LTD11 apr 200511 apr 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul John Jewell come amministratore in data 20 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Miles Skingle come amministratore in data 20 set 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 giu 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Elizabeth Anne Brophy come segretario in data 01 giu 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Timothy John Smyth come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy John Smyth come amministratore in data 12 apr 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road Leeds West Yorkshire LS10 1RJ a The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE in data 12 apr 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Clive Adam Nathan come amministratore in data 06 apr 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Paul John Jewell come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Clive Adam Nathan come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maria Louise Leighton come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian James Barclay come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2016

    Stato del capitale al 25 apr 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    18 pagineAA

    Nomina di Mrs Maria Louise Leighton come amministratore in data 01 nov 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ian James Barclay come amministratore in data 01 nov 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROPHY, Elizabeth Anne
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    247171490001
    SKINGLE, Richard Miles
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritishFinance Director203052180001
    SMYTH, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritishDirector77794000006
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    BritishCompany Secretary139352410001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184077790001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Segretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    BritishDirector75598460002
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    185572230001
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    170325430001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Segretario
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    Segretario
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    37896530011
    BARCLAY, Ian James
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director184779440002
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Amministratore
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritishDirector135540180002
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40471660002
    DAVEY, Jonathan Mark
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81484820003
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director184068890001
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishExecutive Consultant28375870003
    JEWELL, Paul John
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritishCompany Director221544490001
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director233726140001
    LEIGHTON, Maria Louise
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director202291580001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Amministratore
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    EnglandBritishDirector75598460002
    NATHAN, Clive Adam
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director207013760001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Amministratore
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritishChairman139631580001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director107872640001
    SAGGU, Ranvir Singh
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    Amministratore
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant115958310001
    WARREN, Michael Ian
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Operating Officer140310390001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    60471930010

    Chi sono le persone con controllo significativo di UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pbsh Holdings Limited
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 apr 2016
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2016
    Luogo di registrazioneUk Company Register
    Numero di registrazione5297966
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    UK GENERAL MANAGEMENT SERVICES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 13 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £81,907.00.
    Persone aventi diritto
    • Knollys House Limited and Knollys House (No.1) Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2007
    Consegnato il 15 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse,London Branch (Security Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 gen 2006
    Consegnato il 02 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0