WIZARD BONDCO LIMITED

WIZARD BONDCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWIZARD BONDCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05447232
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WIZARD BONDCO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WIZARD BONDCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WIZARD BONDCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WIZARD BONDCO LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WIZARD BONDCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2015

    Stato del capitale al 22 gen 2015

    • Capitale: GBP 50.861001
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Auth capital restriction removed 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Capitalisation authority 30/10/2014
    RES14

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 ott 2014

    • Capitale: GBP 50.861001
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Auth capital restriction revoked 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Authority to capitalise 30/10/2014
    RES14

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 ott 2014

    • Capitale: GBP 4,986,100.14
    4 pagineSH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 ott 2014

    • Capitale: GBP 50.58
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 ott 2014

    • Capitale: GBP 49.86
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Cessazione della carica di Andrew Christopher Carr come amministratore in data 03 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas John Varney come amministratore in data 03 ott 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Fiona Jane Rose come amministratore in data 03 ott 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 28 dic 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2013

    Stato del capitale al 25 nov 2013

    • Capitale: GBP 4,986,099.14
    SH01

    Bilancio redatto al 29 dic 2012

    12 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facilires agreement auth approved 24/06/2013
    RES13

    Iscrizione dell'ipoteca 054472320006

    79 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di WIZARD BONDCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Segretario
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    British172030620001
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    Amministratore
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritish172030620001
    ROSE, Fiona Jane
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Amministratore
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    EnglandBritish93616410002
    CARR, Andrew Christopher
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    Segretario
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    British65490970002
    CORBEN, Darcy
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Segretario
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    British111442510002
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Segretario
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Segretario
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    British100150000001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Amministratore
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BUCKLAND, James Lindsay Carnac
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Amministratore
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British104768550001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Amministratore
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritish65490970003
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Amministratore
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Amministratore
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    EnglandBritish100150000001
    VARNEY, Nicholas John
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Amministratore
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish50480360003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    WIZARD BONDCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 giu 2013
    Consegnato il 03 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Unicredit Bank Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Senior Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 03 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A second confirmatory security agreement
    Creato il 24 mag 2011
    Consegnato il 31 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unicredit Bank Ag London Branch
    Transazioni
    • 31 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A confirmatory security agreement
    Creato il 05 ago 2010
    Consegnato il 20 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unicredit Bank, Ag London Branch
    Transazioni
    • 20 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 26 giu 2008
    Consegnato il 11 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured italian creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 11 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security agreement
    Creato il 21 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured row creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 19 ago 2005
    Consegnato il 31 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 31 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0