TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD

TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05450428
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    QUAYSHELFCO 1152 LIMITED12 mag 200512 mag 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Andrew Davies come amministratore in data 11 mag 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2017 al 31 dic 2017

    1 pagineAA01

    Notifica di Egbert Taylor Management Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 11 ago 2017

    2 paginePSC09

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2016

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Andrew Ratigan come segretario in data 01 nov 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2016

    Stato del capitale al 27 mag 2016

    • Capitale: GBP 15,522.03355
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    12 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2015

    Stato del capitale al 19 mag 2015

    • Capitale: GBP 15,522.03355
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Brendan Francis Murphy come amministratore in data 01 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Davies come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Francis Keegan come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Memorandum e Statuto

    29 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business supplemental amendment agreement obligors agent facility agreement ancillary documents 07/05/2014
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Company business supplemental amendment agreement obligors agent facility agreement ancillary document 02/05/2014
    RES13

    Nomina di Mr Richard Sanders come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, Brendan Francis
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomIrish126815000002
    SANDERS, Richard Barry
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritish188989120001
    COLLINS, Barry David
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    183421870001
    LEWIS, Colin John
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    British103938340001
    RATIGAN, Paul Andrew
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    187270980001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Segretario nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    ANCELL, James Ross
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomNew Zealander5839620005
    CHAPMAN, Richard
    36 Overstone Road
    AL5 5PJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    36 Overstone Road
    AL5 5PJ Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish105780940002
    DAVIES, Andrew
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandWelsh167775130002
    GILLETT, David Alan, Dr
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritish113123610001
    KEEGAN, Nicholas Francis
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritish103638150001
    LEWIS, Colin John
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritish103938340001
    SELKIRK, Peter Ericson
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    UkBritish48130800006
    TAYLOR, Alden Egbert Fenton
    The Shortyard
    DY11 5XF Wolverley
    Sinkers Cottage
    Worcestershire
    Uk
    Amministratore
    The Shortyard
    DY11 5XF Wolverley
    Sinkers Cottage
    Worcestershire
    Uk
    EnglandBritish105780230003
    TAYLOR, Alden Egbert Fenton
    The Shortyard
    DY11 5XF Wolverley
    Sinkers Cottage
    Worcestershire
    Uk
    Amministratore
    The Shortyard
    DY11 5XF Wolverley
    Sinkers Cottage
    Worcestershire
    Uk
    EnglandBritish105780230003
    WARREN, Christopher Laurence
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritish140689400001
    WILLIAMS, David John
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Oak Park, Ryelands Lane
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritish93043120001
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Amministratore delegato nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Oak Park Ryelands Lane
    Worcestershire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Elmley Lovett
    WR9 0QZ Droitwich
    Oak Park Ryelands Lane
    Worcestershire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07794680
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    13 lug 201713 lug 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    TAYLOR CONTINENTAL GROUP LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 14 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital V S.A.R.L.
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 21 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as quayshelfco 1152 limited to the investor security trustee and the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Eci Partners LLP as Security Trustee (The Investor Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 11 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each security provider to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings to the west side of ryelands farm, hartlebury, hereford and worcester and strip of land adjoining ryelands lane t/no HW46646 and HW176492. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0